Michael John FLACK
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Michael |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | FLACK |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 10 |
Total | 15 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRFIELD LDN LIMITED | 17 mai 2018 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Everton Road, The Heath Nr. Sandy SG19 2YQ Bedfordshire ''st Mary's House'' United Kingdom | United Kingdom | British | |
LOWER RICHMOND ROAD PROPERTIES LIMITED | 07 déc. 2012 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Everton Road, The Heath Everton SG19 2YQ Sandy St Mary's House Bedfordshire England | United Kingdom | British | |
FAIRFIELD PROPERTIES (LONDON) LIMITED | 24 juin 1998 | Dissoute | Director | Administrateur | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | |
FAIRFIELD PROPERTIES (LONDON) LIMITED | 24 juin 1998 | Dissoute | Director | Secrétaire | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | British | ||
GREENFLEX ASSOCIATES LIMITED | 26 mars 1991 | Dissoute | Secrétaire | Amp House 2 Cyprus Road Finchley N3 3RY London | British | |||
ASSEMBLY VINTAGE CLOTHING LIMITED | 12 mai 2011 | 21 oct. 2011 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Everton Road The Heath Nr Sandy SG19 2YQ Bedfordshire St Marys House | United Kingdom | British |
PARK HILL CAPITAL LIMITED | 02 juin 2009 | 10 nov. 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British |
LONDON AIR CHARTER CENTRE LIMITED | 23 janv. 2009 | 21 oct. 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British |
CITY SURFACING COMPANY LIMITED | 03 août 2010 | 20 sept. 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Everton Road The Heath Everton SG19 2YQ Sandy "St Mary's House" Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British |
SQUARE KIPPER LIMITED | 20 janv. 2009 | 27 mai 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British |
LONDON AIR CHARTER CENTRE LIMITED | 23 janv. 2009 | 23 janv. 2009 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | British | |
PLAN AHEAD PROJECT MANAGEMENT GROUP LIMITED | 30 juin 2006 | 31 janv. 2008 | Active | Company Director | Administrateur | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British |
Q RESTAURANTS LIMITED | 22 mars 2001 | 15 mai 2002 | Dissoute | Director | Administrateur | St Marys House, Everton Road The Heath, Gamlingay SG19 2YQ Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British |
SLOE HILL RESIDENTIAL HOME LIMITED | 12 mars 1996 | 02 avr. 1999 | Dissoute | Director | Administrateur | Sloe Hill Mill Lane St Ippolyts SG4 7NN Hitchin Hertfordshire | British | |
SLOE HILL RESIDENTIAL HOME LIMITED | 12 mars 1996 | 02 avr. 1999 | Dissoute | Director | Secrétaire | Sloe Hill Mill Lane St Ippolyts SG4 7NN Hitchin Hertfordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0