CHURCH STREET REGISTRARS LTD
Dirigeant de société
Nom | CHURCH STREET REGISTRARS LTD |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 22 |
Total | 23 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
BERG SONS & CO LIMITED | 27 janv. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Peek House 20 Eastcheap EC3M 1EB London | |
HOUSE OF GOLECHHA LIMITED | 13 nov. 2002 | 25 oct. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 20 Eastcheap EC3M 1EB London Peek House United Kingdom |
ADAM NOMINEES LIMITED | 18 juin 1999 | 25 oct. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Ground Floor 20 Eastcheap EC3M 1EB London Peek House United Kingdom |
EVE NOMINEES LIMITED | 18 juin 1999 | 25 oct. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Ground Floor 20 Eastcheap EC3M 1EB London Peek House United Kingdom |
LEVANT GROUP LIMITED | 25 oct. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Eastcheap EC3M 1EB London 20 United Kingdom | |
U.C. GOLECHHA (1974) LIMITED | 30 janv. 2002 | 30 sept. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
HANLON HOLDINGS LIMITED | 31 mai 2006 | 16 août 2010 | Active | Secrétaire | Peek House 20 Eastcheap EC3M 1EB London |
KENSYLDENE LIMITED | 14 mai 1999 | 27 juil. 2009 | Active | Secrétaire | Eastcheap EC3M 1EB London Peek House United Kingdom |
MIJAS PROPERTIES LIMITED | 08 nov. 2002 | 27 juil. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 20 Eastcheap EC3M 1EB London |
PETROCHEMICAL INTERNATIONAL MARKETING COMPANY LIMITED | 21 oct. 2004 | 28 mai 2007 | Dissoute | Secrétaire | Peek House 20 Eastcheap EC3M 1EB London |
GEL WIREMARKERS LIMITED | 19 janv. 2000 | 16 oct. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
QUAY TRADERS LIMITED | 02 août 1999 | 10 mai 2003 | Active | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
TASTE-ITALIA LIMITED | 14 juil. 2002 | 03 janv. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
GULLIVER STUDIOS LIMITED | 01 oct. 2001 | 01 août 2002 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
CHERWOODS LIMITED | 04 avr. 2000 | 01 juin 2002 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
CIPHER PRODUCTIONS LIMITED | 26 oct. 2001 | 10 janv. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
MACTAVISH HEPBURN RESEARCH LIMITED | 29 mars 1995 | 03 avr. 1995 | Active | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
TERMINAL SIX HEATHROW LIMITED | 20 oct. 1994 | 31 janv. 1995 | Active | Administrateur | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
FIRST CITY CARE (NATIONAL) LIMITED | 03 sept. 1993 | 27 juil. 1994 | Dissoute | Administrateur | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
FIRST CITY CARE (LONDON) LIMITED | 18 août 1993 | 27 juil. 1994 | Dissoute | Administrateur | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
SPEYWOOD LIMITED | 24 mars 1993 | 12 juil. 1993 | Active | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
CHASE PROJECTS LIMITED | 25 févr. 1993 | 11 mai 1993 | Active | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
MILESTONE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | 17 mars 1993 | 18 mars 1993 | Dissoute | Secrétaire | Durham House 1 Durham House Street WC2N 6HG London |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0