Christopher John YATES
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Christopher |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | YATES |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 12 |
Total | 16 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCA TRAINING LIMITED | 28 janv. 2025 | Active | Director | Administrateur | Milley Lane Hare Hatch RG10 9AA Reading 2 Waltham Court Berkshire | England | British | |
WALTHAM COURT MANAGEMENT LIMITED | 20 mars 2022 | Active | Chief Executive | Administrateur | Milley Lane Hare Hatch RG10 9TH Reading 2 Waltham Court England | England | British | |
AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INDUSTRY BOARD | 30 sept. 2021 | Active | Chief Executive | Administrateur | Kelvin House 76 Mill Lane SM5 2JR Carshalton Surrey | England | British | |
BERRY'S PLUMBING AND HEATING LIMITED | 11 nov. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | St James Road NN5 5LF Northampton 100 | England | British | |
NATIONAL HOME IMPROVEMENT COUNCIL | 04 oct. 2018 | 26 juin 2023 | Active | Director | Administrateur | Healey House, Dene Road SP10 2AA Andover Suite 2 Hampshire United Kingdom | England | British |
CORGI SERVICES LIMITED | 01 mars 2018 | 31 août 2021 | Active | Director | Administrateur | Winchester Street SP10 2EA Andover Aldwych House Hampshire United Kingdom | England | British |
GISG | 10 avr. 2012 | 10 déc. 2020 | Active | Managing Director | Administrateur | 26 & 28 High Street DE74 2DA Kegworth Igem House Derbyshire England | England | British |
RIVERS REACH MANAGEMENT CO. LIMITED | 17 avr. 2018 | 02 avr. 2020 | Active | Company Director | Administrateur | 6a St. Andrew Street SG14 1JA Hertford Saxon House Hertfordshire England | England | British |
JOHNSON & STARLEY LIMITED | 17 sept. 2013 | 26 janv. 2018 | Active | Director | Administrateur | Rhosili Road Brackmills NN4 7LZ Northampton | England | British |
CRANFIELD ELECTRONICS LIMITED | 19 juin 2015 | 26 janv. 2018 | Dissoute | Director | Administrateur | Rhosili Road NN4 7LZ Northampton Johnson & Starley Ltd England | England | British |
JOHNSON AND STARLEY PROPERTY LIMITED | 11 nov. 2013 | 26 janv. 2018 | Dissoute | Director | Administrateur | Rhosili Road Brackmills NN4 7LZ Northampton 8 | England | British |
BOULTER BUDERUS LIMITED | 29 nov. 2002 | 31 mars 2006 | Dissoute | Director | Administrateur | 20 Brewhouse Lane SG14 1TZ Hertford Hertfordshire | England | British |
OCK MILL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 13 juin 1991 | 01 déc. 2005 | Active | Business Planning Manager | Administrateur | 15 Ock Mill Close Marcham Road OX14 1SP Abingdon Oxfordshire | British | |
BULLOUGH HEATING LIMITED | 19 janv. 1998 | 29 nov. 2002 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | 20 Brewhouse Lane SG14 1TZ Hertford Hertfordshire | England | British |
OFTEC LIMITED | 01 mai 2001 | 01 mai 2002 | Active | Managing Director | Administrateur | 20 Brewhouse Lane SG14 1TZ Hertford Hertfordshire | England | British |
OCK MILL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 04 mars 1994 | 01 déc. 1995 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15 Ock Mill Close Marcham Road OX14 1SP Abingdon Oxfordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0