Joanne MILLER
Personne physique
| Titre | Mrs |
|---|---|
| Prénom | Joanne |
| Nom de famille | MILLER |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 2 |
| Inactif | 4 |
| Démissionné | 7 |
| Total | 13 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERLAND ESTATES LIMITED | 10 févr. 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | The Business Centre Faringdon Avenue RM3 8EN Romford Suite D Essex United Kingdom | England | British | |
| DANBURY PROPERTIES LIMITED | 18 janv. 2007 | Dissoute | Secretary | Secrétaire | Suite D, The Business Centre Faringdon Avenue RM3 8EN Romford | British | ||
| MCO CONSULTING LTD. | 16 déc. 2005 | Active | Director | Administrateur | Suite D, The Business Centre Faringdon Avenue RM3 8EN Romford Essex | England | British | |
| MCO DEVELOPMENTS LIMITED | 05 mai 2005 | Dissoute | Director | Secrétaire | 15-17 Roebuck Road Hainault Business Park IG6 3TU Ilford Recovery House Essex | British | ||
| MCO DEVELOPMENTS LIMITED | 05 mai 2005 | Dissoute | Director | Administrateur | 15-17 Roebuck Road Hainault Business Park IG6 3TU Ilford Recovery House Essex | England | British | |
| MCO CONSULTING LTD. | 07 mars 2001 | Active | Secrétaire | Suite D, The Business Centre Faringdon Avenue RM3 8EN Romford Essex | British | |||
| MCO INVESTMENTS LIMITED | 29 mai 2015 | 06 août 2024 | Active | Director | Administrateur | Faringdon Avenue RM3 8EN Romford Suite D The Business Centre Essex United Kingdom | England | British |
| MCO MARYLEBONE (THREE) LIMITED | 12 mars 2014 | 30 sept. 2014 | Active | Director | Administrateur | Faringdon Ave RM3 8EN Romford Suite D The Business Centre Essex United Kingdom | England | British |
| BLUE ROCK ESTATES LIMITED | 19 juin 2006 | 24 sept. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 123 Springfield Gardens RM14 3ET Upminster Essex | British | ||
| CREST NICHOLSON (RAINSFORD ROAD) LIMITED | 21 mars 2007 | 13 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 123 Springfield Gardens RM14 3ET Upminster Essex | British | ||
| SPRINGFIELD BARGES LIMITED | 01 nov. 2002 | 28 janv. 2003 | Active | Property Developer | Secrétaire | 123 Springfield Gardens RM14 3ET Upminster Essex | British | |
| SPRINGFIELD BARGES LIMITED | 01 nov. 2002 | 10 janv. 2003 | Active | Property Developer | Administrateur | 123 Springfield Gardens RM14 3ET Upminster Essex | England | British |
| HAROLD WOOD PROPERTIES LIMITED | 29 août 1995 | 01 oct. 1996 | Active | Director | Administrateur | 123 Springfield Gardens RM14 3ET Upminster Essex | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0