Peter Martin DAVIES
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Peter |
Deuxième prénom | Martin |
Nom de famille | DAVIES |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 15 |
Total | 17 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED PACKAGING PUBLIC LIMITED COMPANY | 21 août 2001 | Liquidation | Director | Administrateur | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | England | British | |
UNITED PACKAGING PUBLIC LIMITED COMPANY | 21 août 2001 | Liquidation | Director | Secrétaire | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | British | ||
LTH (KENT) HOLDINGS LIMITED | 11 mai 2018 | 27 sept. 2021 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate United Kingdom | England | British |
SAGA TRUCK & VAN HOLDINGS LTD | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Active | Accountant | Administrateur | Eurolink Industrial Estate Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 England | England | British |
RCM GB LTD | 11 oct. 2017 | 21 nov. 2019 | Active | Accountant | Administrateur | Eurolink Industrial Estate Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 England | England | British |
ROONEY TRUCK & VAN LIMITED | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
TWODRIVE LIMITED | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
KENT AND SUSSEX VEHICLE HOLDINGS LIMITED | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
KENT AND SUSSEX TRUCK CENTRE LIMITED | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
ALL-COMM PARTS LIMITED | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
ROONEY DAVIES LIMITED | 27 mars 2018 | 21 nov. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
SAGA TRUCK & VAN LTD | 27 mars 2018 | 20 nov. 2019 | Active | Accountant | Administrateur | Castle Road ME10 3RN Sittingbourne Unit 10 Eurolink Industrial Estate England | England | British |
M J MAILLIS (UK) LIMITED | 18 févr. 2002 | 31 mars 2013 | Active | Accountant | Administrateur | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | England | British |
SAMUEL STRAPPING TRUSTEES LIMITED | 27 juin 2003 | 31 mars 2013 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | England | British |
PACKAGE PENSION FUND TRUSTEES LIMITED | 18 déc. 2002 | 31 mars 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | England | British |
PRECIS (935) LIMITED | 20 août 2002 | 31 mars 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | England | British |
ACME GERRARD LIMITED | 20 août 2002 | 31 mars 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 3 Central Avenue LE2 1TB Leicester Leicestershire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0