CHARLOTTE SECRETARIES LIMITED
Dirigeant de société
Nom | CHARLOTTE SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 6 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 109 |
Total | 120 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
DEFENSOR TRUSTEES LIMITED | 31 mars 2021 | Active | Secrétaire | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Floor, 1 Exchange Crescent Scotland | |
VINDEX NOMINEES LIMITED | 31 mars 2021 | Active | Secrétaire | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Floor, 1 Exchange Crescent Scotland | |
DEFENSOR TRUSTEES (2001) LIMITED | 31 mars 2021 | Active | Secrétaire | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Floor, 1 Exchange Crescent Scotland | |
VINDEX TRUSTEES LIMITED | 31 mars 2021 | Active | Secrétaire | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Floor, 1 Exchange Crescent Scotland | |
MOORE HOUSE NOMINEES LIMITED | 31 mars 2021 | Active | Secrétaire | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Floor, 1 Exchange Crescent Scotland | |
LYCIDAS TRUSTEE COMPANY LIMITED | 31 mars 2021 | Active | Secrétaire | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Floor, 1 Exchange Crescent Scotland | |
NORTHSTREAM LIMITED | 03 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Floor 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Lothian United Kingdom | |
NORTHSTREAM HOLDINGS LIMITED | 03 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Floor 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Lothian United Kingdom | |
MASTECH (SCOTLAND) LTD. | 01 févr. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Saltire Court Midlothian United Kingdom | |
EDGEMOND PROPERTIES LIMITED | 28 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Floor, 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th United Kingdom | |
UK STORAGE AND DISTRIBUTION LIMITED | 09 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian | |
MARKET OPERATOR SERVICES LIMITED | 23 oct. 2014 | 12 nov. 2014 | Active | Administrateur | 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UK Edinburgh 5th Floor Lothian United Kingdom |
OPEN WATER MARKET LIMITED | 26 nov. 2013 | 31 janv. 2014 | Dissoute | Administrateur | Floor 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th Lothian United Kingdom |
BRIDGE NORTH SEA (CENTRAL) LIMITED | 17 oct. 2007 | 07 nov. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Exchange Cresent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 United Kingdom |
CARBO CERAMICS (UK) LIMITED | 23 nov. 2007 | 19 mars 2012 | Dissoute | Secrétaire | Floor 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5th United Kingdom |
LAUGE FARMING LIMITED | 16 mars 2007 | 09 mars 2012 | Dissoute | Secrétaire | Golden Square AB10 1RB Aberdeen 9 Scotland |
MORECAMBE WIND LIMITED | 29 avr. 2005 | 02 déc. 2009 | Active | Secrétaire | Floor 1 Exchange Crescent Conference Square EH3 8UL Edinburgh 5 Great Britain |
PRESERVE LIMITED | 06 juin 2006 | 02 oct. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
SURGEONS HALL TRUST | 27 juin 2002 | 01 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
FQC PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 26 mai 2006 | 16 mars 2009 | Active | Secrétaire | 9 Golden Square AB10 1RB Aberdeen |
GREENFERN BAKERY LIMITED | 26 mai 2006 | 16 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | 9 Golden Square AB10 1RB Aberdeen |
CALEDON GREEN LIMITED | 27 févr. 2008 | 26 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | 9 Golden Square AB10 1RB Aberdeen |
CALEDON GREEN HOLDINGS LIMITED | 27 févr. 2008 | 26 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | 9 Golden Square AB10 1RB Aberdeen |
KUEHNE + NAGEL DRINKFLOW ASSET CONTROL LIMITED | 23 nov. 2007 | 28 nov. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
MATRIX ANALYTICS LIMITED | 30 déc. 2005 | 02 mai 2007 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (GLASGOW) | 08 avr. 2004 | 01 mars 2007 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (DUNDEE) | 30 juin 2003 | 01 mars 2007 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
MAGGIE'S TRADING LIMITED | 30 juin 2003 | 01 mars 2007 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (HIGHLANDS) | 03 déc. 2004 | 01 mars 2007 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (LANARKSHIRE) | 28 août 2003 | 01 mars 2007 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (EDINBURGH) | 30 juin 2003 | 01 mars 2007 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (FIFE) | 30 juin 2003 | 01 mars 2007 | Dissoute | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
LAUNCHCHANGE FINANCE LIMITED | 13 déc. 2006 | 15 déc. 2006 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
VIDEOJET TECHNOLOGIES LIMITED | 06 déc. 2006 | 13 déc. 2006 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
TGA INDUSTRIES LIMITED | 06 déc. 2006 | 13 déc. 2006 | Active | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0