Kathryn Ethel SENA
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Kathryn |
Deuxième prénom | Ethel |
Nom de famille | SENA |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 28 |
Total | 30 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIONICS MOBILE SERVICES LIMITED | 01 nov. 2007 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
TH ACQUISITION COMPANY LIMITED | 14 juin 2004 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
MUIRHEAD AEROSPACE LIMITED | 03 nov. 2008 | 11 janv. 2017 | Active | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
AEM LIMITED | 01 nov. 2007 | 11 janv. 2017 | Active | Company Secretary | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | |
TAYLOR HOBSON TRUSTEES LIMITED | 04 oct. 2007 | 11 janv. 2017 | Active | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
AMETEK SCP (BARROW) LIMITED | 17 avr. 2007 | 11 janv. 2017 | Active | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
LAND INSTRUMENTS INTERNATIONAL LIMITED | 15 juin 2006 | 11 janv. 2017 | Active | Company Secretary | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | |
SOLARTRON METROLOGY LIMITED | 26 sept. 2005 | 11 janv. 2017 | Active | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
TAYLOR HOBSON LIMITED | 18 juin 2004 | 11 janv. 2017 | Active | Company Secretary | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | |
AIRTECHNOLOGY PENSION TRUSTEES LIMITED | 11 déc. 2003 | 11 janv. 2017 | Active | Corporate Secretary | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | |
AMETEK (GB) LIMITED | 14 nov. 2003 | 11 janv. 2017 | Active | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
AMETEK AIRTECHNOLOGY GROUP LIMITED | 14 nov. 2003 | 11 janv. 2017 | Active | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
AMETEK RUSSIA (UK) LIMITED | 08 avr. 2009 | 11 janv. 2017 | Dissoute | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
EMA HOLDINGS UK LIMITED | 14 nov. 2003 | 11 janv. 2017 | Dissoute | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
VISION RESEARCH LIMITED | 25 juil. 2008 | 05 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
AMETEK PRECISION INSTRUMENTS (UK) LTD. | 04 oct. 2007 | 05 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
SPECTRO ANALYTICAL UK LIMITED | 03 oct. 2007 | 05 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | New Star Road LE4 9LQ Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | Other | ||
CAMECA U.K. LIMITED | 16 août 2007 | 01 mai 2014 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
TAYLOR HOBSON OVERSEAS LIMITED | 18 juin 2004 | 04 janv. 2013 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | |
TAYLOR HOBSON HOLDINGS LIMITED | 18 juin 2004 | 04 janv. 2013 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | |
AMETEK HOLDINGS (UK) LIMITED | 22 juil. 2009 | 15 août 2012 | Dissoute | Corporate Officer | Administrateur | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Usa | Other |
NORCROFT DYNAMICS LIMITED | 03 nov. 2008 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
AVIATION WINDINGS LIMITED | 01 nov. 2007 | 15 août 2012 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | |
AEROMEDIC INNOVATIONS LIMITED | 01 nov. 2007 | 15 août 2012 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | |
SOLARTRON INSTRUMENTS LIMITED | 26 sept. 2005 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
SOLARTRON METROLOGY 2001 LIMITED | 26 sept. 2005 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
AIRTECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | 14 nov. 2003 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
AIRCONTROL TECHNOLOGIES LIMITED | 14 nov. 2003 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
AMETEK HOLDINGS (UK) LIMITED | 14 nov. 2003 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other | ||
AIRSCREW LIMITED | 14 nov. 2003 | 15 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | 24 Henredon Drive Phoenixville Pa 19460 Usa | Other |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0