Michael Andrew TUCKER
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Michael |
| Deuxième prénom | Andrew |
| Nom de famille | TUCKER |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 11 |
| Démissionné | 22 |
| Total | 34 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWTU PHARMA CONSULT LTD | 17 déc. 2016 | Active | Administrateur | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | United Kingdom | British | ||
| HEALTHY IDEAS LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| GALPHARM TRADING LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| HEALTHY IDEAS LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| GALPHARM TRADING LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| ENPROFEN LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| PAN-EUROPEAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| PAN-EUROPEAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| ENPROFEN LIMITED | 09 janv. 2008 | Dissoute | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| BARUM LIMITED | 30 juin 2005 | Dissoute | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | ||
| WRAFTON TRUSTEES LIMITED | 16 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| BARUM LIMITED | 16 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | |||
| PRIMROSE TOPCO LIMITED | 19 juin 2020 | 22 mai 2025 | Active | Administrateur | Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street LS11 9XE Leeds Rosemont House England | United Kingdom | British | |
| PRIMROSE BIDCO LIMITED | 19 juin 2020 | 22 mai 2025 | Active | Administrateur | Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street LS11 9XE Leeds Rosemont House England | United Kingdom | British | |
| THE NORTH DEVON BIOSPHERE FOUNDATION | 30 sept. 2019 | 04 janv. 2022 | Active | Administrateur | Spring Close Northam EX39 1TY Bideford 2 Devon England | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT GROUP LIMITED | 11 févr. 2013 | 31 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT HOLDINGS LIMITED | 11 févr. 2013 | 31 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT TRUSTEE COMPANY LIMITED | 11 févr. 2013 | 31 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ACACIA BIOPHARMA LIMITED | 11 févr. 2013 | 31 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT PENSIONS LIMITED | 11 févr. 2013 | 31 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | 11 févr. 2013 | 31 oct. 2016 | Active | Administrateur | Wrafton EX33 2DL Braunton Devon | United Kingdom | British | |
| PERRIGO UK ACQUISITION LIMITED | 06 mars 2009 | 31 oct. 2016 | Active | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| PERRIGO PHARMA LIMITED | 17 juin 2008 | 31 oct. 2016 | Active | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| KITEACRE LIMITED | 09 janv. 2008 | 31 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | 09 janv. 2008 | 31 oct. 2016 | Active | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| GALPHARM INTERNATIONAL LIMITED | 09 janv. 2008 | 31 oct. 2016 | Active | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| WRAFTON LABORATORIES LIMITED | 01 nov. 2002 | 31 oct. 2016 | Active | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British | |
| PERRIGO PHARMA LIMITED | 17 juin 2008 | 27 mai 2014 | Active | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| KITEACRE LIMITED | 09 janv. 2008 | 27 mai 2014 | Dissoute | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | 09 janv. 2008 | 27 mai 2014 | Active | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| GALPHARM INTERNATIONAL LIMITED | 09 janv. 2008 | 27 mai 2014 | Active | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| WRAFTON LABORATORIES LIMITED | 16 mai 1998 | 27 mai 2014 | Active | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| BRUNEL HEALTHCARE MANUFACTURING LIMITED | 11 déc. 2003 | 17 juin 2008 | Active | Secrétaire | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | British | ||
| BRUNEL HEALTHCARE MANUFACTURING LIMITED | 11 déc. 2003 | 17 juin 2008 | Active | Administrateur | 2 Spring Close Northam EX39 1TY Bideford North Devon | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0