Peter Gerard GORVIN
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Peter |
| Deuxième prénom | Gerard |
| Nom de famille | GORVIN |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 20 |
| Total | 21 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ASHTON HOMES LTD | 22 août 2014 | Dissoute | Retired | Administrateur | 45 The Downs WA14 2QG Altrincham Grosvenor House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| LIVING POSITIVELY LIMITED | 31 mars 2003 | 05 août 2016 | Active | Solicitor | Secrétaire | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | British | |
| RAINS & SON LIMITED | 01 nov. 2013 | 25 nov. 2014 | Active | Retired | Administrateur | Upper Langwith Collingham LS22 5DQ Wetherby September Place West Yorkshire England | United Kingdom | British |
| BEECHWOOD CANCER CARE CENTRE | 17 juil. 2002 | 30 sept. 2007 | Active | Solicitor | Secrétaire | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | British | |
| BEECHWOOD CANCER CARE CENTRE | 13 juil. 2001 | 30 sept. 2007 | Active | Solicitor | Administrateur | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | United Kingdom | British |
| RICHARD GUEST HORSERACING LIMITED | 10 mai 2006 | 22 juin 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | United Kingdom | British |
| STOCKPORT CANAL BOAT TRUST FOR DISABLED PEOPLE | 08 avr. 1999 | 01 mai 2005 | Active | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | ||
| CASUAL DINING HOLDINGS PLC | 08 nov. 2002 | 31 déc. 2004 | Dissoute | Secrétaire | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | British | ||
| CASUAL DINING HOLDINGS PLC | 01 déc. 2002 | 30 déc. 2004 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | United Kingdom | British |
| PSMW DISTRIBUTORS LIMITED | 16 mai 2002 | 27 juin 2003 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | September Place Upper Langwith LS22 5DQ Collingham West Yorkshire | United Kingdom | British |
| DEAN HOUSE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 30 sept. 1994 | 04 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | ||
| BLANTYRE DEVELOPMENTS LIMITED | 30 sept. 1999 | 14 mars 2002 | Receveur désigné | Director | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | |
| DEAN HOUSE LIMITED | 30 sept. 1994 | 01 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | ||
| GK FORMATIONS ONE LIMITED | 17 févr. 1998 | 19 déc. 2001 | Active | Solicitor | Administrateur | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | |
| GK FORMATIONS TWO LIMITED | 16 févr. 1998 | 19 déc. 2001 | Active | Solicitor | Administrateur | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | |
| SKYMART HOLDINGS LIMITED | 08 déc. 1999 | 05 nov. 2001 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | |
| CHAMBERTIN CAPITAL (UK) LIMITED | 28 juin 1999 | 16 avr. 2001 | Active | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | ||
| POLYTECH INTERNATIONAL LIMITED | 21 mars 1997 | 24 févr. 1999 | Active | Solicitor | Administrateur | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | |
| POLYTECH INTERNATIONAL LIMITED | 25 févr. 1997 | 24 févr. 1999 | Active | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | ||
| STOCKPORT PAWNBROKERS LIMITED | 12 avr. 1996 | 11 févr. 1997 | Active | Solicitor | Administrateur | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British | |
| SOVEREIGN RUBBER LIMITED | 10 mai 1996 | 21 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire | Chadlea House 36 Bunkers Hill Romiley SK6 3DS Stockport Cheshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0