Stuart Mark SHAW
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Stuart |
Deuxième prénom | Mark |
Nom de famille | SHAW |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 26 |
Total | 31 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH UTILITIES LTD | 18 oct. 2017 | Dissoute | Company Director | Administrateur | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesketh Mount Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | |
ASHLEY SHAW LEGAL LIMITED | 10 janv. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Lord Street PR8 1JR Southport 92-96 United Kingdom | United Kingdom | British | |
RDS AUDIT LTD | 11 juin 2007 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesket Mount Merseyside England | British | ||
RDS AUDIT LTD | 16 juin 2006 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesketh Mount Merseyside | United Kingdom | British | |
BIRKDALE PARK DEVELOPMENTS LTD | 05 mai 2004 | Dissoute | Co Director | Administrateur | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesketh Mount Merseyside | England | British | |
CARING SOLUTIONS (UK) LTD | 01 déc. 2012 | 16 oct. 2018 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Clovelly Drive PR8 3AJ Southport 23 England | United Kingdom | British |
SHAW LEGAL LTD. | 02 août 2011 | 01 sept. 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | Lord Street PR8 1JR Southport 96 United Kingdom | United Kingdom | British |
CSK UTILITIES LTD | 29 nov. 2013 | 01 déc. 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesketh Mount England | United Kingdom | British |
DIMENSIONS, DESIGN & FIT LTD | 11 juin 2007 | 01 août 2014 | Dissoute | Director | Secrétaire | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesketh Mount Merseyside | British | |
AZTEC CIVIL ENGINEERING LTD | 03 juin 2013 | 13 janv. 2014 | Dissoute | Certified Accountant | Administrateur | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesket Mount Merseyside England | United Kingdom | British |
PAINTBOX ART MEDIA LTD | 01 nov. 2011 | 12 déc. 2013 | Active | Accountant | Administrateur | 43 Castle Street L2 9TL Liverpool Castle Chambers Merseyside | United Kingdom | British |
DIMENSIONS, DESIGN & FIT LTD | 28 juin 2002 | 15 oct. 2012 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 92-96 Lord Street PR8 1JR Southport Hesketh Mount Merseyside | England | British |
EASY - ID LTD | 14 avr. 2000 | 20 févr. 2004 | Dissoute | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | ||
A & E PROPERTIES (SOUTHPORT) LIMITED | 21 janv. 2000 | 19 janv. 2004 | Active | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | ||
EUTOPIA ASSOCIATES LTD | 07 janv. 2002 | 31 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | ||
DIRECT HYGIENE O.C.S. LIMITED | 12 févr. 2001 | 21 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | ||
WALSH INVESTMENTS LIMITED | 21 juin 2000 | 12 juil. 2003 | Active | Secrétaire | 6 Liverpool Road Birkdale PR8 4AR Southport | British | ||
CONTRACT SITE SERVICES (SOUTHPORT) LTD | 02 juil. 2001 | 27 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | ||
DAVIS LITERARY CONSULTANCY LTD | 06 juin 2002 | 25 juin 2003 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | |
NORWARD LIMITED | 07 juin 2000 | 25 juin 2003 | Liquidation | Secrétaire | 6 Liverpool Road Birkdale PR8 4AR Southport | British | ||
J.J. SMITH TECHNICAL SERVICES LTD | 29 mai 2001 | 23 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | ||
ZACKSPEK ENTERPRISES LIMITED | 19 août 1998 | 19 mai 2003 | Active | Secrétaire | 6 Liverpool Road Birkdale PR8 4AR Southport | British | ||
DAWN SECURITY SERVICES LTD | 25 avr. 2001 | 07 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | ||
HAMBLEDON GRANGE FINANCIAL SERVICES LTD | 15 juin 2001 | 05 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | ||
CTO CONSULTANCY LIMITED | 01 sept. 2000 | 01 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | ||
N & S INVESTMENTS LTD | 07 juin 2001 | 11 oct. 2002 | Active | Accountant | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | |
CURLY WOODWIND LIMITED | 22 août 2000 | 11 oct. 2002 | Active | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | ||
A & E PROPERTIES (SOUTHPORT) LIMITED | 04 juil. 2001 | 10 sept. 2002 | Active | Accountant | Administrateur | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British | |
STUART BROWN GARDENING SERVICES LTD | 11 juin 2002 | 27 juin 2002 | Active | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | ||
RIMMER ROOFING & RENOVATIONS LTD | 11 juin 2002 | 27 juin 2002 | Active | Secrétaire | 9 Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport Merseyside | British | ||
PERSPECTIVE PSYCHOTHERAPY LIMITED | 07 mars 2001 | 11 juin 2002 | Active | Secrétaire | 41a Weld Road Birkdale PR8 2DS Southport Merseyside | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0