Graham SMITH
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Graham |
| Nom de famille | SMITH |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 3 |
| Inactif | 4 |
| Démissionné | 20 |
| Total | 27 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE TYNESIDE GOLF CLUB TRADING LIMITED | 09 mars 2022 | Active | Administrateur | Station Road NE39 1QD Rowlands Gill The Bungalow United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| ZENITH HOMES (CHOPPINGTON) LTD | 10 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Station Road NE39 1QD Rowlands Gill The Bungalow Tyne And Wear | British | |||
| ZENITH HOMES (CHOPPINGTON) LTD | 10 janv. 2008 | Dissoute | Administrateur | Station Road NE39 1QD Rowlands Gill The Bungalow Tyne And Wear | United Kingdom | British | ||
| ZENITH DEVELOPMENT HOMES LIMITED | 13 févr. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Station Road NE39 1QD Rowlands Gill The Bungalow Tyne And Wear | British | |||
| ZENITH DEVELOPMENT HOMES LIMITED | 13 févr. 2007 | Dissoute | Administrateur | Station Road NE39 1QD Rowlands Gill The Bungalow Tyne And Wear | United Kingdom | British | ||
| WILCOMM BESPOKE LIVING LIMITED | 17 juil. 2006 | Receveur désigné | Secrétaire | Windsor Court NE39 1BF Rowlands Gill 4 Tyne And Wear | British | |||
| WILCOMM BESPOKE LIVING LIMITED | 01 mai 2005 | Receveur désigné | Administrateur | Windsor Court NE39 1BF Rowlands Gill 4 Tyne And Wear | British | |||
| EMPOWER COMMUNITY FOUNDATION | 26 mai 2016 | 16 mai 2019 | Active | Administrateur | Queen Street Place EC4R 1BE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RMG PPM REALISATIONS LIMITED | 13 juil. 2016 | 14 juil. 2016 | Dissoute | Administrateur | North Road DH9 8UJ Stanley Hare Law Industrial Estate County Durham England | United Kingdom | British | |
| RMG REALISATIONS LIMITED | 13 juil. 2016 | 14 juil. 2016 | Dissoute | Administrateur | 2 Emperor Way SR3 3XR Sunderland Emperor House Tyne And Wear | United Kingdom | British | |
| TIMEC 1301 LIMITED | 31 janv. 2011 | 30 juin 2011 | Dissoute | Administrateur | St Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham | United Kingdom | British | |
| BANKS SUSTAINABLE LIVING LIMITED | 05 janv. 2010 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | St. Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| BATES REGENERATION LIMITED | 05 janv. 2010 | 30 juin 2011 | Dissoute | Administrateur | St. Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| BANKS ESH LIMITED | 04 janv. 2010 | 30 juin 2011 | Dissoute | Administrateur | St Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| SHERATON PARK MANAGEMENT LIMITED | 28 juil. 2009 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | St. Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| THE BANKS GROUP LIMITED | 23 déc. 2008 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | St John's Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| ONPATH ENERGY LIMITED | 23 déc. 2008 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | St. Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| BANKS DEVELOPMENTS LIMITED | 26 sept. 2008 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | St Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| BANKS PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 07 août 2008 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | 2nd Floor, Block C Brandon Gate, Leechlee Road ML3 6AU Hamilton Lanarkshire | United Kingdom | British | |
| BANKS PROPERTY LIMITED | 05 août 2008 | 30 juin 2011 | Active | Administrateur | St Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| BANKS MOUNT OSWALD LIMITED | 05 janv. 2010 | 01 mars 2011 | Dissoute | Administrateur | St Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham England | United Kingdom | British | |
| PRIMROSE GARDENS (RYTON) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15 juin 2006 | 17 déc. 2008 | Active | Secrétaire | Station Road NE39 1QD Rowlands Gill The Bungalow Tyne And Wear | British | ||
| MARQUESS POINT PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 01 févr. 2006 | 30 nov. 2007 | Active | Secrétaire | 6 Newminster Place Bullers Green NE61 1BF Morpeth Northumberland | British | ||
| J12 PROPERTIES LTD | 01 juin 2006 | 28 sept. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 6 Newminster Place Bullers Green NE61 1BF Morpeth Northumberland | British | ||
| J12 PROPERTIES LTD | 17 janv. 2006 | 28 sept. 2006 | Dissoute | Administrateur | 6 Newminster Place Bullers Green NE61 1BF Morpeth Northumberland | British | ||
| LAUNCHPAD HOMES LIMITED | 08 sept. 2005 | 28 sept. 2006 | Active | Administrateur | 6 Newminster Place Bullers Green NE61 1BF Morpeth Northumberland | British | ||
| LAUNCHPAD HOMES LIMITED | 08 sept. 2005 | 28 sept. 2006 | Active | Secrétaire | 6 Newminster Place Bullers Green NE61 1BF Morpeth Northumberland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0