Jonathan Mark KENDALL
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Jonathan |
| Deuxième prénom | Mark |
| Nom de famille | KENDALL |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 13 |
| Démissionné | 21 |
| Total | 35 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALIS TRAINING LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| RAIL TRAINING AUDIT SERVICES LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| RTAS SERVICES LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| FAIRBOURNE ADVENTURE LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| THE FAIRBOURNE HOTEL LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| ATA RAIL RECRUITMENT LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| COLLEGE OF RAILWAY TECHNOLOGY LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| SLOAN SHRAGO LIMITED | 10 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | |||
| GEM-WELD (UK) LTD. | 05 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | British | |||
| CATALIS LIMITED | 24 juil. 2007 | Dissoute | Administrateur | Tottle Road NG2 1RT Nottingham Cartwright House | United Kingdom | British | ||
| CATALIS LIMITED | 24 juil. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Tottle Road NG2 1RT Nottingham Cartwright House | British | |||
| TROCHUS PLC | 29 nov. 2004 | Dissoute | Administrateur | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | United Kingdom | British | ||
| TROCHUS PLC | 28 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | British | |||
| POVOAS PACKAGING LIMITED | 12 juin 2001 | Active | Administrateur | Stoke Albany Road Desborough NN14 2SR Kettering Northamptonshire | United Kingdom | British | ||
| RTC GROUP PLC | 23 mars 2010 | 22 juil. 2010 | Active | Administrateur | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | United Kingdom | British | |
| GLOBAL CHOICE RECRUITMENT LIMITED | 23 avr. 2009 | 22 juil. 2010 | Dissoute | Administrateur | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | United Kingdom | British | |
| ATA SELECTION LIMITED | 10 mars 2009 | 22 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| ATA GLOBAL STAFFING SOLUTIONS LIMITED | 10 mars 2009 | 22 juil. 2010 | Active | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| GLOBAL CHOICE RECRUITMENT LIMITED | 10 mars 2009 | 22 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| CATALIS GROUP LIMITED | 10 mars 2009 | 22 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| ATA RECRUITMENT LIMITED | 25 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| ATA RECRUITMENT LIMITED | 25 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Administrateur | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | United Kingdom | British | |
| GANYMEDE SOLUTIONS LIMITED | 24 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Administrateur | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | United Kingdom | British | |
| THE DERBY CONFERENCE CENTRE LIMITED | 24 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Administrateur | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | United Kingdom | British | |
| THE DERBY CONFERENCE CENTRE LIMITED | 24 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| GANYMEDE SOLUTIONS LIMITED | 24 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| ATA MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 17 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | British | ||
| ATA MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 17 juil. 2007 | 22 juil. 2010 | Dissoute | Administrateur | The Derby Conference Centre London Road DE24 8UX Derby | United Kingdom | British | |
| RTC GROUP PLC | 05 juin 2007 | 22 juil. 2010 | Active | Secrétaire | London Road Alvaston DE24 8UX Derby The Derby Conference Centre | British | ||
| POVOAS PACKAGING LIMITED | 05 juil. 2004 | 20 juil. 2009 | Active | Secrétaire | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | British | ||
| SRS TECHNOLOGY LTD. | 30 nov. 2004 | 30 oct. 2006 | Dissoute | Administrateur | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | United Kingdom | British | |
| SRS TECHNOLOGY LTD. | 28 juin 2004 | 30 oct. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | British | ||
| IMAGELINX UK LIMITED | 04 juil. 2000 | 10 mai 2004 | Dissoute | Administrateur | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | United Kingdom | British | |
| IMAGELINX UK LIMITED | 04 juil. 2000 | 10 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 438 Kedleston Road Allestree DE22 2TG Derby | British | ||
| DUPLE (METSEC) LIMITED | 15 nov. 1999 | 30 juin 2000 | Dissoute | Administrateur | 27 Iris Close B29 5BS Birmingham West Midlands | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0