Stephen John PARROTT
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Stephen |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | PARROTT |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 10 |
Démissionné | 25 |
Total | 35 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDINBURGH DISTRIBUTION SERVICES LIMITED | 30 juin 2009 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
NUMITOR LIMITED | 02 juin 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
A. N. C. (SOUTH YORKSHIRE) LIMITED | 28 mars 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
PRICE TRANSPORT GROUP LIMITED | 28 mars 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
PTG LIMITED | 28 mars 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED | 15 déc. 2006 | Dissoute | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
ANC GROUP TRUSTEES LIMITED | 15 déc. 2006 | Dissoute | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
ANC TRUSTEES NO. 2 LIMITED | 15 déc. 2006 | Dissoute | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
ANC INTERNATIONAL LIMITED | 15 déc. 2006 | Dissoute | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED | 15 déc. 2006 | Dissoute | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. | 01 nov. 2001 | 20 mars 2017 | Active | Business Executive | Administrateur | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House | Uk | British |
FEDERAL EXPRESS FINANCE LIMITED | 09 avr. 1996 | 20 mars 2017 | Liquidation | Business Executive | Administrateur | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | Uk | British |
ANC HOLDINGS (1995) LIMITED | 15 déc. 2006 | 28 févr. 2017 | Active | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
ANC BUSINESS SERVICES LIMITED | 15 déc. 2006 | 28 févr. 2017 | Active | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
ANC GROUP LIMITED | 15 déc. 2006 | 28 févr. 2017 | Active | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
FEDEX UK LIMITED | 15 déc. 2006 | 28 févr. 2017 | Active | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
ANC HOLDINGS LIMITED | 17 sept. 2007 | 28 févr. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
ANC LIMITED | 17 sept. 2007 | 28 févr. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
ESPRIT IN-NIGHT EXPRESS LIMITED | 17 sept. 2007 | 28 févr. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | ||
FEDERAL EXPRESS FINANCE LIMITED | 09 avr. 1996 | 28 févr. 2017 | Liquidation | Financial Controller | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
FEDERAL EXPRESS (NI) LIMITED. | 15 mars 2011 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Financial Controller | Administrateur | Bedford Street BT2 7FW Belfast 50 Northern Ireland | England | British |
FEDEX (NI) LIMITED | 22 juin 1989 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Secrétaire | C/O Cleaver Fulton Rankin 50 Bedford Street BT2 7FW Belfast | British | ||
FEDEX (NI) LIMITED | 22 juin 1989 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Financial Controller | Administrateur | C/O Cleaver Fulton Rankin 50 Bedford Street BT2 7FW Belfast | England | British |
DENCOM FREIGHT HOLDINGS LIMITED | 16 juil. 1975 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Secrétaire | Bedford Street BT2 7FW Belfast 50 Northern Ireland | British | ||
DENCOM FREIGHT HOLDINGS LIMITED | 16 juil. 1975 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Financial Controller | Administrateur | Bedford Street BT2 7FW Belfast 50 Northern Ireland | England | British |
DENCOM INVESTMENTS LIMITED | 12 juin 1973 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Secrétaire | C/O Cleaver Fulton Rankin 50 Bedford Street BT2 7FW Belfast | British | ||
DENCOM INVESTMENTS LIMITED | 12 juin 1973 | 31 déc. 2016 | Liquidation | Financial Controller | Administrateur | C/O Cleaver Fulton Rankin 50 Bedford Street BT2 7FW Belfast | England | British |
FEDERAL EXPRESS (NI) LIMITED. | 31 déc. 2016 | Liquidation | Secrétaire | Bedford Street BT2 7FW Belfast 50 Northern Ireland | British | |||
FEDEX UK SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED | 15 déc. 2006 | 16 déc. 2014 | Active | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
FEDEX UK HOLDINGS LIMITED | 15 déc. 2006 | 16 déc. 2014 | Active | Business Executive | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | |
FEDERAL EXPRESS (UK) PENSION TRUSTEES LIMITED | 08 mars 1996 | 26 nov. 2013 | Active | Secrétaire | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House | British | ||
FEDERAL EXPRESS (UK) PENSION TRUSTEES LIMITED | 08 févr. 1996 | 26 nov. 2013 | Active | Business Executive | Administrateur | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House | Uk | British |
FEDERAL EXPRESS (NI) LIMITED. | 15 mars 2011 | Liquidation | Financial Controller | Administrateur | 15 Riverview Croft The Shrubberies CV4 7HB Coventry England | British | ||
MARCHAMONT ESTATES LIMITED | 09 avr. 1996 | 08 mai 1998 | Dissoute | Financial Controller | Secrétaire | 15 Riverford Croft The Shrubberies CV4 7HB Coventry Midlands | British | |
MARCHAMONT ESTATES LIMITED | 09 avr. 1996 | 08 mai 1998 | Dissoute | Financial Controller | Administrateur | 15 Riverford Croft The Shrubberies CV4 7HB Coventry Midlands | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0