Adam Charles Edward PEAKE
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Adam |
| Deuxième prénom | Charles Edward |
| Nom de famille | PEAKE |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 5 |
| Démissionné | 36 |
| Total | 41 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PINCH OF LOVE LIMITED | 19 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | |||
| SLG215 PROPERTIES | 20 sept. 2007 | Dissoute | Administrateur | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | England | British | ||
| TERRAVENT LIMITED | 11 mars 2005 | Dissoute | Secrétaire | c/o Peake & Co 27-28 Clement's Lane EC4N 7AE London St Clements House England | British | |||
| S & B FABRICATION (SWINDON) LIMITED | 04 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | |||
| NOVATION TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | 16 mars 1998 | Dissoute | Secrétaire | c/o Peake & Co 27-28 Clement's Lane EC4N 7AE London St Clements House England | British | |||
| PLUMB COMPUTERS LIMITED | 29 août 2002 | 26 sept. 2012 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| HAMMER GALLERIES LIMITED | 01 mars 2001 | 01 mai 2012 | Active | Secrétaire | c/o Peake & Company 27-28 Clement's Lane EC4N 7AE London St Clements House England | British | ||
| ITAX CONSULTING UK LIMITED | 15 déc. 2006 | 02 déc. 2010 | Active | Administrateur | 27-28 Clements Lane EC4N 7AE London St Clements House England | England | British | |
| MILLER'S COURT TENANTS LIMITED | 15 août 1994 | 01 nov. 2010 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| ANNALEA HOLDINGS LTD | 11 déc. 2007 | 01 juil. 2010 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| NATURE'S NURSERY (ASCOT) LIMITED | 03 juil. 2008 | 15 févr. 2010 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| NATURES NURSERY (LEES) LIMITED | 20 mars 2008 | 15 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| NATURES NURSERY (ROYTON) LIMITED | 11 déc. 2007 | 15 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| NATURES NURSERY LIMITED | 11 déc. 2007 | 15 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| NATURES NURSERY (MIDDLETON) LIMITED | 11 déc. 2007 | 15 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| ARC ADVENTURE (SUSSEX) LTD | 11 déc. 2007 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| ARC ADVENTURE (BURY) LTD | 11 déc. 2007 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| ARC CHILDRENS HOMES LIMITED | 11 déc. 2007 | 01 oct. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| YORK MANSIONS (BAKER STREET) LIMITED | 17 sept. 1998 | 03 sept. 2009 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| PELAGON LIMITED | 03 juin 2005 | 10 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| UPSTANCE RESIDENTS COMPANY LIMITED | 15 juil. 2002 | 27 févr. 2009 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| RICHMOND BRIDGE ESTATE MANAGEMENT COMPANY PHASE 1 LIMITED | 25 oct. 2005 | 07 nov. 2008 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| RICHMOND BRIDGE ESTATE MANAGEMENT COMPANY PHASE 2 LIMITED | 25 oct. 2005 | 07 nov. 2008 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| OLD PYE HOUSE LIMITED | 03 févr. 1998 | 09 mai 2008 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| TERRAVENT LIMITED | 11 mars 2005 | 31 mars 2008 | Dissoute | Administrateur | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | England | British | |
| HILL OLDRIDGE LIMITED | 15 sept. 1997 | 21 déc. 2007 | Active | Secrétaire | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | British | ||
| HILL OLDRIDGE LIMITED | 26 oct. 1994 | 21 déc. 2007 | Active | Administrateur | 363 Upper Richmond Road West SW14 7NX London | England | British | |
| B.B.H.S. MANAGEMENT LIMITED | 12 nov. 1993 | 13 oct. 2006 | Active | Administrateur | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| LONDON TENNIS LIMITED | 22 janv. 2003 | 19 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| THE PERSONAL TRAINING CENTRE LIMITED | 04 janv. 2001 | 21 févr. 2003 | Active | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| THE LONDON FITNESS CONSULTANCY LIMITED | 26 nov. 1998 | 21 févr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| 11 DUKE STREET LIMITED | 13 déc. 1996 | 15 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| TOPBEAT LIMITED | 01 juin 1996 | 15 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| HEATHFIELD COURT (CHISWICK) LIMITED | 23 août 2000 | 30 avr. 2001 | Active | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | ||
| ORION TRADING EMEA LIMITED | 27 août 1998 | 10 janv. 2000 | Active | Secrétaire | 21 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0