MCA REGISTRARS LIMITED
Dirigeant de société
Nom | MCA REGISTRARS LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 9 |
Inactif | 11 |
Démissionné | 61 |
Total | 81 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
FORWARD WORLDWIDE LIMITED | 26 mai 2023 | Active | Administrateur | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
AGILE SERVICES LTD | 01 févr. 2012 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
BELLE CUDEX LIMITED | 15 août 2010 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
ELITE MODELS LIMITED | 01 juin 2009 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
FIVESTAR AMVAN LIMITED | 19 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
ABBAZABA LIMITED | 08 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
MEADE ENTERPRISE LIMITED | 22 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
SYNAPSE SEVEN LTD | 01 juin 2006 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
NEUTRON 2 LIMITED | 01 janv. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
T M WOOD DESIGN LIMITED | 03 oct. 2005 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
VERULAM PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 23 août 2005 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
THOMAS JAMES HOLDINGS LIMITED | 10 août 2005 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
J P P W LIMITED | 05 août 2005 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
T.D. GEER LIMITED | 11 nov. 2004 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
AH PARTNERSHIP LIMITED | 15 oct. 2004 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
ELCO LIGHTING LIMITED | 23 sept. 2004 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
AVOCET SERVICES LIMITED | 22 avr. 2004 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
ACCURATE BOOKKEEPING COMPANY LIMITED | 07 mai 2003 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
HARRISON PRINT SERVICES LIMITED | 23 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
JAYNE REESE LIMITED | 15 août 2002 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom | |
EEXXSS LIMITED | 22 oct. 2004 | 05 avr. 2017 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
CAPITAL TO COAST LIMITED | 02 juil. 2007 | 25 avr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
P.K.P. OPTICS LIMITED | 12 nov. 2004 | 31 déc. 2015 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
LOXOR LTD | 07 févr. 2007 | 13 avr. 2015 | Active | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
CARAVAN AND LEISURE TECHNOLOGY LIMITED | 01 janv. 2006 | 06 août 2013 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
DELTA COMPONENTS 2 LIMITED | 01 janv. 2006 | 29 sept. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
DELTASENSE LIMITED | 01 janv. 2006 | 29 sept. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
LOOK CAR AND COMMERCIAL VEHICLE SALES COMPANY LIMITED | 14 nov. 2007 | 28 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
NORDELETTRONICA UK LTD | 01 janv. 2006 | 26 nov. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
DELTA COMPONENTS EUROPE LIMITED | 01 janv. 2006 | 25 nov. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dartford Road TN13 3TE Sevenoaks Stanley House Kent United Kingdom |
BISHOPS COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | 04 sept. 2001 | 01 juin 2008 | Active | Secrétaire | Temple House 34-36 High Street TN13 1JG Sevenoaks Kent |
SPORTY TOTS (SOUTH EAST) LIMITED | 10 mars 2006 | 11 mars 2006 | Dissoute | Secrétaire | Temple House 34-36 High Street TN13 1JG Sevenoaks Kent |
NEIL YATES RECOVERY LIMITED | 25 juin 2001 | 01 août 2005 | Active | Secrétaire | Temple House 34-36 High Street TN13 1JG Sevenoaks Kent |
ALCO PLANT HIRE LIMITED | 02 janv. 2001 | 01 août 2005 | Active | Secrétaire | Temple House 34-36 High Street TN13 1JG Sevenoaks Kent |
SILVERCREST TRANSPORT LIMITED | 08 oct. 2001 | 24 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | Temple House 34-36 High Street TN13 1JG Sevenoaks Kent |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0