Julian Wesley Lee PLEWS
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Julian |
Deuxième prénom | Wesley Lee |
Nom de famille | PLEWS |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 20 |
Total | 25 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOWPLA PLASTICS LIMITED | 08 mars 2018 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 6th Floor Bank House 8 Cherry Street B2 5AL Birmingham Baldwins Restructuring And Insolvency | England | English | |
NATURAL FERTILISERS LIMITED | 23 déc. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Owen Street LE67 3DE Coalville Coalville Business Park Leicestershire England | England | English | |
BLACKSMITH END MANAGEMENT LIMITED | 29 juil. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | 25 Blacksmith End LE14 4EZ Stathern The Bickern Leicestershire England | England | English | |
GARDEN-TECHNOLOGY LIMITED | 01 sept. 2008 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Coalville Business Park Owen Street LE67 3DE Coalville Leicestershire | England | English | |
SHOWPLA PLASTICS LIMITED | 18 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 6th Floor Bank House 8 Cherry Street B2 5AL Birmingham Baldwins Restructuring And Insolvency | English | |||
ORGANICO LIMITED | 23 déc. 2014 | 31 mai 2021 | Active | Director | Administrateur | Owen Street LE67 3DE Coalville C/O Vitax Ltd Leicestershire England | England | English |
JOHN HALL (FERTILISERS) LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 mai 2021 | Active | Accountant | Administrateur | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | England | English |
VITAX LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 mai 2021 | Active | Accountant | Administrateur | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | England | English |
THOMAS ELLIOTT LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 mai 2021 | Active | Accountant | Administrateur | Coalville Business Park Owen Street LE67 3DE Coalville C/O Synchemicals Ltd Leicestershire | England | English |
CORRY AND COMPANY,LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 mai 2021 | Active | Accountant | Administrateur | Vitax Ltd, Coalville Business Park, Owen Street LE67 3DE Coalville Leicesterdhire | England | English |
SYNCHEMICALS LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 mai 2021 | Active | Accountant | Administrateur | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | England | English |
SPREAD GARDEN SUPPLIES LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 mai 2021 | Active | Accountant | Administrateur | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | England | English |
NUTREL PRODUCTS LIMITED | 03 sept. 2007 | 31 mai 2021 | Active | Director | Administrateur | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | England | English |
SLUG GONE LIMITED | 15 juin 2012 | 31 mai 2021 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Owen Street LE67 3DE Coalville Synchemicals Limited Leicestershire | England | English |
HORTIFEEDS INTERNATIONAL LIMITED | 08 mai 2012 | 31 mai 2021 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | England | English |
THOMAS ELLIOTT LIMITED | 18 juin 2007 | 01 janv. 2012 | Active | Secrétaire | Coalville Business Park Owen Street LE67 3DE Coalville C/O Synchemicals Ltd Leicestershire | English | ||
SPREAD GARDEN SUPPLIES LIMITED | 28 avr. 1993 | 01 janv. 2012 | Active | Secrétaire | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | English | ||
CORRY AND COMPANY,LIMITED | 21 avr. 1993 | 01 janv. 2012 | Active | Secrétaire | Vitax Ltd, Coalville Business Park, Owen Street LE67 3DE Coalville Leicesterdhire | English | ||
SYNCHEMICALS LIMITED | 21 avr. 1993 | 01 janv. 2012 | Active | Secrétaire | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | English | ||
GARDEN-TECHNOLOGY LIMITED | 09 août 2001 | 01 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Coalville Business Park Owen Street LE67 3DE Coalville Leicestershire | English | ||
HORTIFEEDS INTERNATIONAL LIMITED | 07 mai 1998 | 01 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | English | ||
NUTREL PRODUCTS LIMITED | 03 sept. 2007 | 12 déc. 2011 | Active | Director | Secrétaire | Owen Street Coalville LE67 3DE Leicestershire | English | |
JOHN HALL (FERTILISERS) LIMITED | 18 mai 1998 | 30 oct. 2009 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 9 Church Lane NG13 0JD Plungar Nottinghamshire | English | |
VITAX LIMITED | 21 avr. 1993 | 30 oct. 2009 | Active | Secretary | Secrétaire | 9 Church Lane NG13 0JD Plungar Nottinghamshire | English | |
SHOWPLA PLASTICS LIMITED | 14 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 Church Lane NG13 0JD Plungar Nottinghamshire | English |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0