Michael David WILMOT-WILKINSON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Michael |
Deuxième prénom | David |
Nom de famille | WILMOT-WILKINSON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 6 |
Total | 14 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASHINGTON FINANCE LIMITED | 22 févr. 2021 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | Brook Avenue Warsash SO31 9HP Southampton Liberty House United Kingdom | England | British | |
E.COM COMPUTER SYSTEMS LIMITED | 11 avr. 2006 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Liberty House 37 Mitchell Point Ensign Way Hamble SO31 4RF Southampton Hampshire | British | ||
LIMO CONVERSION SALES LIMITED | 24 janv. 2003 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 37 Mitchell Point, Ensign Way, Hamble SO31 4RF Southampton Liberty House Hampshire | British | ||
UNIVERSAL MACHINE SYSTEMS LIMITED | 19 avr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 51 Merdon Avenue Chandlers Ford SO53 1GD Eastleigh Hampshire | British | |||
CHANGELANE LIMITED | 01 mai 2001 | Dissoute | Secrétaire | Brook Avenue Warsash SO31 9HP Southampton Liberty House Hampshire | British | |||
NATHANIEL BUTT (THE VILLAGE GARAGE) LIMITED | 16 mars 2001 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Liberty House 37 Mitchell Point Ensign Way Hamble SO31 4RF Southampton Hampshire | British | ||
PICKWICK ESTATES LIMITED | 01 janv. 2001 | Active | Accountant | Secrétaire | Brook Avenue SO31 9HP Warsash Liberty House Southampton Hampshire | British | ||
PICKWICK ESTATES LIMITED | 01 janv. 2001 | Active | Accountant | Administrateur | Brook Avenue SO31 9HP Warsash Liberty House Southampton Hampshire | England | British | |
SHINEDOWN LIMITED | 12 août 2013 | 12 mai 2022 | Liquidation | Chartered Accountant | Administrateur | Solent Business Park Whiteley PO15 7FP Fareham Plot 4300 Hampshire | England | British |
PLANTATION PROPERTY COMPANY LIMITED | 11 févr. 2002 | 04 nov. 2019 | Dissoute | Secrétaire | Leigh Road SO50 9DR Eastleigh 99 Hampshire | British | ||
DAWNSHORE LIMITED | 19 juin 2002 | 30 avr. 2017 | Active | Secrétaire | 51 Merdon Avenue Chandlers Ford SO53 1GD Eastleigh Hampshire | British | ||
LIBERTY LEASING LIMITED | 10 oct. 2001 | 01 févr. 2015 | Active | Secrétaire | Brook Avenue Warsash SO31 9HP Southampton Liberty House Hampshire Great Britain | British | ||
FIRST LEASING UK LTD | 22 mars 2002 | 30 sept. 2003 | Active | Secrétaire | 51 Merdon Avenue Chandlers Ford SO53 1GD Eastleigh Hampshire | British | ||
XCSL LIMITED | 08 mai 1996 | 26 mai 1998 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | 51 Merdon Avenue Chandlers Ford SO53 1GD Eastleigh Hampshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0