Steven John BENNETT
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Steven |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | BENNETT |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 30 |
Total | 31 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBY PROPERTIES (ENFIELD) LIMITED | 01 déc. 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British | |
MARKS AND SPENCER 2005 (WARRINGTON GEMINI STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (CHESTER STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (KINGSTON-ON-THAMES STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (KINGSTON-ON-THAMES SATELLITE STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER (PROPERTY VENTURES) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
SIMPLY FOOD (PROPERTY INVESTMENTS) | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (GLASGOW SAUCHIEHALL STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (PUDSEY STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (HEDGE END STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (CHESTER SATELLITE STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Dissoute | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (PARMAN HOUSE KINGSTON STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (BROOKLANDS STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (KENSINGTON STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER 2005 (FIFE ROAD KINGSTON STORE) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
SIMPLY FOOD (PROPERTY VENTURES) LIMITED | 14 sept. 2018 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
RUBY PROPERTIES (TUNBRIDGE) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS & SPENCER SIMPLY FOODS LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
BUSYEXPORT LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
RUBY PROPERTIES (THORNCLIFFE) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER (BRADFORD) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | 35 North Wharf Road W2 1NW London Waterside House United Kingdom | England | British |
RUBY PROPERTIES (LONG EATON) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER (INITIAL LP) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | No 2 Lochrin Square 96 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh | England | British |
AMETHYST LEASING (PROPERTIES) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
RUBY PROPERTIES (HARDWICK) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
MARKS AND SPENCER CHESTER LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
AMETHYST LEASING (HOLDINGS) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
RUBY PROPERTIES (CUMBERNAULD) LIMITED | 01 déc. 2016 | 29 août 2019 | Active | Director | Administrateur | Waterside House 35 North Wharf Road W2 1NW London | England | British |
TP DIRECTORS LTD | 20 juil. 2015 | 19 déc. 2016 | Active | Surveyor | Administrateur | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British |
ACCESSIBLE RETAIL LIMITED | 05 mai 2011 | 20 mai 2015 | Active | None | Administrateur | High Street CO5 9JA Kelvedon 163 Essex | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0