Jonathan HART
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Jonathan |
Nom de famille | HART |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 10 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 14 |
Total | 28 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROADHURST CAPITAL LIMITED | 02 oct. 2020 | Active | Lawyer | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
SAFE GLOBAL LIMITED | 21 août 2019 | Active | Lawyer | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
CLAUGHTON HOLDINGS LIMITED | 03 déc. 2018 | Active | Solicitor | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
GEOBIO LIMITED | 09 déc. 2015 | Active | Lawyer | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
GH GENERAL PARTNER LIMITED | 26 oct. 2015 | Dissoute | Lawyer | Administrateur | 115 High Street OX18 4RG Burford Wysdom Hall Oxfordshire England | United Kingdom | British | |
SEAK GLOBAL LIMITED | 09 juil. 2015 | Active | Lawyer | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
WYSDOM HALL LIMITED | 09 mai 2014 | Active | Lawyer | Administrateur | Trofts Byworth GU28 0HN Nr Petworth Trofts West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | |
TILFORD PROPERTIES LIMITED | 09 mai 2014 | Dissoute | Lawyer | Administrateur | Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Cloatley Manor Wiltshire England | United Kingdom | British | |
12 EGERTON GARDENS FREEHOLD LIMITED | 22 avr. 2014 | Active | Director | Administrateur | Trofts Byworth GU28 0HN Nr Petworth Trofts West Sussex United Kingdom | England | British | |
60 PGM FREEHOLD LIMITED | 02 déc. 2012 | Active | Lawyer | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
ZAPP (UK) LIMITED | 03 mai 2005 | Dissoute | Secrétaire | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | British | |||
ZAPP (IP) LIMITED | 03 mai 2005 | Dissoute | Secrétaire | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | British | |||
CAMERON HART LIMITED | 25 juin 2004 | Active | Secrétaire | Byworth GU28 0HN Nr Petworth Trofts West Sussex United Kingdom | British | |||
REGWILL INVESTMENTS LIMITED | 19 juin 1998 | Active | Solicitor | Administrateur | Princes Gate Mews SW7 2PR London 60 England | England | British | |
FRANK SMYTHSON LIMITED | 06 mai 2023 | 16 déc. 2024 | Active | Lawyer | Administrateur | 257a Pavilion Road SW1X 0BP London 257a Pavilion Road England | United Kingdom | British |
APUS SEQUESTRATION LLP | 05 avr. 2006 | 04 avr. 2024 | Dissoute | Membre de la LLP | Hyde Street SO23 7TA Winchester 16 City Business Centre England | United Kingdom | ||
PROMETHEUS GREEN LLP | 05 avr. 2006 | 03 avr. 2024 | Dissoute | Membre de la LLP | Hyde Street SO23 7TA Winchester 16 City Business Centre England | United Kingdom | ||
MAIA GREEN LLP | 05 avr. 2006 | 03 avr. 2024 | Dissoute | Membre de la LLP | Hyde Street SO23 7TA Winchester 16 City Business Centre England | United Kingdom | ||
RHEA CARBON LLP | 05 avr. 2006 | 03 avr. 2024 | Dissoute | Membre de la LLP | Hyde Street SO23 7TA Winchester 16 City Business Centre England | United Kingdom | ||
CAMCO ONE LIMITED | 22 déc. 2017 | 01 avr. 2022 | Active | Solicitor | Administrateur | Earls Court Road Kensington W8 6EJ London 52 United Kingdom | United Kingdom | British |
AMIGDALA TECHNOLOGIES LIMITED | 11 août 2016 | 20 sept. 2016 | Dissoute | Lawyer | Administrateur | Admiralty Park Station Road, Holton Heath BH16 6HX Poole St. Vincent House Dorset England | United Kingdom | British |
ECHOMAN PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 11 févr. 2008 | 02 juin 2010 | Active | Lawyer | Administrateur | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British |
INQUAM TELECOM (HOLDINGS) LIMITED | 05 nov. 2001 | 22 nov. 2004 | Liquidation | Secrétaire | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | British | ||
INQUAM TELECOM (HOLDINGS) LIMITED | 08 juin 2002 | 16 janv. 2003 | Liquidation | Lawyer | Administrateur | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British |
OASIS MEDICAL SOLUTIONS LIMITED | 03 sept. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | British | |||
HYDRO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED | 30 nov. 1995 | 30 juin 1997 | Active | Solicitor | Administrateur | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British |
HYDRO INTERNATIONAL DATA, INSIGHT & ANALYSIS LTD | 22 mars 1995 | 30 juin 1997 | Active | Secrétaire | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | British | ||
HYDRO INTERNATIONAL LIMITED | 14 nov. 1994 | 30 juin 1997 | Active | Company Director | Administrateur | Cloatley Manor Cloatley Road Hankerton SN16 9LQ Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0