• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Catherine Julia SUTTON

    Personne physique

    TitreMrs
    PrénomCatherine
    Deuxième prénomJulia
    Nom de familleSUTTON
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif9
    Inactif1
    Démissionné12
    Total22

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    AIRBORNE ALLERGY ACTION C.I.C.10 avr. 2018ActiveChartered Company SecretaryAdministrateur
    Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    28
    EnglandBritish
    CAPITAL QUIZMASTER LTD.01 mars 2017ActiveChartered Company SecretaryAdministrateur
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    EnglandBritish
    BONUSLINKS LIMITED01 mars 2017ActiveChartered Company SecretaryAdministrateur
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    EnglandBritish
    ENGINE COMPUTING LIMITED24 nov. 2005ActiveChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    ENGINE COMPUTING LIMITED24 nov. 2005ActiveChartered Company SecretaryAdministrateur
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    EnglandBritish
    URSUS VENTURES LIMITED16 juin 2004ActiveSecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    LAWNSIDE LIMITED08 août 2003DissouteChartered Company SecretaryAdministrateur
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    EnglandBritish
    CAPITAL QUIZMASTER LTD.31 janv. 2002ActiveChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    BONUSLINKS LIMITED12 mai 2000ActiveCompany SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    HOCKOURT NO.5 LIMITED16 mars 1998LiquidationSecrétaire
    11 Lawnside
    Blackheath
    SE3 9HR London
    British
    MOON BROTHERS LIMITED16 mars 199815 janv. 2015DissouteSecrétaire
    11 Lawnside
    Blackheath
    SE3 9HR London
    British
    HEATHLEE MANAGEMENT COMPANY LIMITED(THE)25 mai 200507 oct. 2014ActiveSecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    HEATHLEE MANAGEMENT COMPANY LIMITED(THE)25 mai 200507 oct. 2014ActiveChartered Company SecretaryAdministrateur
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    EnglandBritish
    AUTOMOTIVE PR LIMITED27 nov. 200631 mai 2010ActiveChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    MOBILICITY PPT SYSTEMS LIMITED14 déc. 200631 mai 2010DissouteCompany SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    ORB PR LIMITED27 nov. 200631 mai 2010DissouteChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    ORB COMMUNICATIONS GROUP LIMITED27 nov. 200631 mai 2010DissouteChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    LAWNSIDE LIMITED08 août 200301 janv. 2007DissouteChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    PLANT HEALTH CARE (UK) LIMITED18 juil. 200531 déc. 2006ActiveChartered Company SecretarySecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    PLANT HEALTH CARE LIMITED30 juin 200531 déc. 2006ActiveSecrétaire
    28 Lee Park
    Blackheath
    SE3 9HU London
    British
    FAIREY NO. 2 LIMITED02 déc. 199731 mai 2002DissouteSecrétaire
    11 Lawnside
    Blackheath
    SE3 9HR London
    British
    TIL 83 LIMITED30 sept. 199922 oct. 2001DissouteSecrétaire
    11 Lawnside
    Blackheath
    SE3 9HR London
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0