Chloé MOORE
Personne physique
Titre | Ms |
---|---|
Prénom | Chloé |
Nom de famille | MOORE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 35 |
Total | 35 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATIONAL CARE GROUP HOLDINGS LIMITED | 24 juin 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 United Kingdom | England | British |
UNIFIED RESOURCES LIMITED | 17 mai 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
INTEGRA COMMUNITY LIVING OPTIONS LIMITED | 17 mai 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
UNIFIED PROPERTY SERVICES LIMITED | 17 mai 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
OAKLEA CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
NEWFIELD VIEW SUPPORTED LIVING | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
SHELTON CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
FACE 2 FACE CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 The Globe Centre England | England | British |
NATIONAL NEUROLOGICAL SERVICES LTD | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
CORNERSTONES (UK) LTD | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
CHOSEN CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
WESTWARD CARE HOMES LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
ENDURANCE CARE LTD. | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
WELLINGTON SUPPORT LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
HIGHLEA CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
ATLANTIC WAY CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 United Kingdom | England | British |
JAMESON'S RESIDENTIAL HOME LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
ESSENTIAL CARE & SUPPORT LTD | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
AFFINITY SUPPORTING PEOPLE (SOUTH) LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
MERRY DEN CARE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
CARE ASSURE NORTHAMPTON LTD | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
REGENT COLLEGE LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
YOUR LIFE CARE AND SUPPORT LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
SHELTON CARE HOLDINGS LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
KINDSTREAM LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
NORTH WESTERN HOUSING LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
HARVARD HOMES SERVICES LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
WESTWARD CAPITAL HOLDINGS LTD | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
ACCESS HOUSING LIMITED | 01 mars 2019 | 31 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
AFFINITY SUPPORTING PEOPLE | 01 mars 2019 | 30 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
NATIONAL CARE GROUP LTD | 01 mars 2019 | 30 août 2020 | Active | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
HIGHLEA HOMES LIMITED | 01 mars 2019 | 30 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
SUNNYFIELD SUPPORT SERVICES LTD | 01 mars 2019 | 30 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
NATIONAL CARE HOMES LIMITED | 01 mars 2019 | 30 août 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
RICHMOND CARE HOMES LIMITED | 01 mars 2019 | 31 juil. 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | The Globe Centre St James Square BB5 0RE Accrington Suite 22 England | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0