Patrick Mark HARTREY
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Patrick |
Deuxième prénom | Mark |
Nom de famille | HARTREY |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 118 |
Total | 121 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE ORIGINAL TOOL HIRE COMPANY LIMITED | 02 juin 2009 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | ||
HIRE SHOPS LIMITED | 02 juin 2009 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | ||
HSS HIRE SHOPS (GERMANY) LIMITED | 02 juin 2009 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | ||
HSS SERVICE GROUP LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | |
HSS HIRE LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | |
HSS TRAINING LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | |
1ST COLLECTION SERVICES LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Willow Lane CR4 4TS Mitcham 25 Surrey England | British | |
HSS SERVICE FINANCE LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | |
A1 HIRE AND SALES LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | Willow Lane CR4 4TS Mitcham 25 Surrey Uk | British | |
HSS HIRE SERVICE HOLDINGS LIMITED | 02 juin 2009 | 27 janv. 2017 | Dissoute | Chartrered Secretary | Secrétaire | 25 Willow Lane Mitcham CR4 4TS Surrey | British | |
UNIVERSAL EXPORTS LIMITED | 06 déc. 2001 | 16 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Room 1, The Undercroft, St George's Church 6-7 Little Russell Street WC1A 2HR London C/O Jeremy Meadow Ltd England | British | |
UNIVERSAL EXPORTS LIMITED | 06 déc. 2001 | 16 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British |
PERFECT CHANGE PRODUCTIONS LIMITED | 24 mai 2005 | 11 nov. 2016 | Active | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | British | ||
JEREMY MEADOW LIMITED | 10 mai 2005 | 11 nov. 2016 | Active | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | British | ||
SUZANNA ROSENTHAL PRODUCTIONS LIMITED | 19 juil. 2006 | 11 août 2016 | Active | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | British | ||
TEG PRODUCTIONS LIMITED | 24 mai 2005 | 11 août 2016 | Active | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | British | ||
MEADOW ROSENTHAL LTD | 29 août 2007 | 11 août 2016 | Dissoute | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | British | ||
TEG PRODUCTIONS (THEATRE) LIMITED | 25 avr. 2005 | 11 août 2016 | Dissoute | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey | British | ||
SOMETHING FOR THE WEEKEND LTD | 19 juil. 2006 | 06 avr. 2016 | Active | Secrétaire | Convent Close GU22 8DS Woking 3 Surrey United Kingdom | British | ||
SIX CONTINENTS HOTELS INTERNATIONAL LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Active | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
IHG HOTELS LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Active | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SIX CONTINENTS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Active | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SCIH BRANSTON 3 | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
HOTEL FORUM | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SSABCO LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SCIH BRANSTON 2 | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SC INVESTMENTS NUMBER 2 | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SC WINE BARS UNLIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
BBJV INVESTMENTS LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SC INVESTMENTS NUMBER 3 | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
HOLIDAY INNS (ENGLAND) LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
SC NAS 2 LIMITED | 13 nov. 2007 | 20 juin 2008 | Liquidation | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
ALPHA CEREALS UNLIMITED | 29 avr. 2006 | 20 oct. 2006 | Active | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
CENTURA FOODS LIMITED | 29 avr. 2006 | 20 oct. 2006 | Active | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | ||
RH OLDCO LIMITED | 29 avr. 2006 | 20 oct. 2006 | Active | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0