Cheryl Ann HANCOCK
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Cheryl |
| Deuxième prénom | Ann |
| Nom de famille | HANCOCK |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 3 |
| Démissionné | 12 |
| Total | 15 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCKTON BROOK INVESTMENTS LIMITED | 15 oct. 2009 | Dissoute | Administrateur | Cheddleton ST13 7EP Nr Leek Churnet Grange Staffordshire | England | British | ||
| TIDE POWER SYSTEMS INTERNATIONAL LTD | 01 janv. 2009 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | ||
| MYBAY LIMITED | 29 oct. 2007 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | ||
| LEASE CARS 4 YOU LIMITED | 16 mars 2010 | 13 juin 2011 | Dissoute | Administrateur | Station Road ST13 7EP Cheddleton Churnet Grange Staffordshire England | England | British | |
| CHURNET HOLIDAY LODGES LIMITED | 27 oct. 2009 | 01 oct. 2010 | Dissoute | Administrateur | Station Road ST13 7EP Cheddleton Churnet Grange Staffordshire | England | British | |
| TIDE POWER SYSTEMS UK LTD | 07 avr. 2009 | 23 sept. 2009 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | |
| FAST TRACK DEVELOPERS LIMITED | 27 juin 2006 | 28 juin 2009 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | |
| BENTLEY AUCTIONS CENTRE LIMITED | 29 mai 2009 | 30 mai 2009 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | |
| BENTLEY ESTATE AGENTS LIMITED | 30 avr. 2009 | 01 mai 2009 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | |
| POWERPLUS INTERNATIONAL LIMITED | 18 janv. 2008 | 31 oct. 2008 | Dissoute | Administrateur | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | England | British | |
| POWERPLUS INTERNATIONAL LIMITED | 08 août 2007 | 31 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Churnet Grange ST13 7EP Cheddleton Staffordshire | British | ||
| TROJAN ESTATES (SW) LIMITED | 01 déc. 2005 | 20 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Stanton House Stanley Road ST9 9LJ Stoke On Trent Staffordshire | British | ||
| TROJAN ESTATES (SW) LIMITED | 01 déc. 2005 | 20 nov. 2006 | Dissoute | Administrateur | Stanton House Stanley Road ST9 9LJ Stoke On Trent Staffordshire | British | ||
| CC DEVELOPMENTS (SW) LIMITED | 01 déc. 2005 | 20 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Stanton House Stanley Road ST9 9LJ Stoke On Trent Staffordshire | British | ||
| CC DEVELOPMENTS (SW) LIMITED | 01 déc. 2005 | 20 nov. 2006 | Dissoute | Administrateur | Stanton House Stanley Road ST9 9LJ Stoke On Trent Staffordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0