Nicholas James HEARD
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Nicholas |
Deuxième prénom | James |
Nom de famille | HEARD |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 45 |
Total | 45 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIRD CLOTHING MENSWEAR LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WB INDUSTRIAL LTD. | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
BAIRD CLOTHING LINGERIE LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WEST AUCK NO. 25 LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
MATTHEW ROYCE (DEVON) LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
TELEMAC LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WILLIAM BAIRD INDUSTRIAL LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WEST AUCK NO.48 LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
COLLAGE BRANDS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
MATTHEW ROYCE SOFTWARE LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
JACQUES VERT (WHOLESALE) LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WESTERN REVERSION TRUST, LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY | British | |
STYLE GROUP BRANDS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
PLANET FASHIONS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
BAIRD CLOTHING LADIESWEAR LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY | British | |
BAIRDTEX LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
THOMAS MARSHALL INVESTMENTS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
COLLAGE FASHIONS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
J R CLOTHES LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WEST AUCK NO. 50 LIMITED | 29 ao ût 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
JACQUES VERT BRANDS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
STUDIO 23 COLLECTION LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WEST AUCK NO. 49 LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
DANNIMAC LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
MONKLAND FINANCE LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
BAIRD TEXTILE HOLDINGS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY | British | |
SEQUEL DIRECT LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
COUNTY SHIRT COMPANY LIMITED THE | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY | British | |
CLOUD NINE LONDON LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
ALAIN CANNELLE LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
RICHARD I.RACKE LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
WINDSMOOR (PRECIS) LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
BAIRD MENSWEAR BRANDS LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | |
DANNIMAC MANUFACTURING LIMITED | 29 août 2008 | 31 déc. 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0