John Lambie TALLO
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | John |
Deuxième prénom | Lambie |
Nom de famille | TALLO |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 12 |
Démissionné | 8 |
Total | 20 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVONSIDE GROUP LIMITED | 23 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE GROUP HOLDINGS TRUSTEES LIMITED | 20 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED | 20 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE TRUSTEES LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE COUNTRY HOMES LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE HOUSES LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
AVONSIDE HOLDINGS LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
FINCHWOLD LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
J.E. PARRY (ROSSETT) LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
JOSHUA AND TOM TAYLOR LIMITED | 18 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
GRAMPIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 13 janv. 2000 | Dissoute | Self-Employed | Administrateur | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
GRAMPIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 01 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
PARRY HOMES LIMITED | 18 sept. 2003 | 22 janv. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
VERICORE LIMITED | 10 déc. 1998 | 19 janv. 2000 | Active | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
ELANCO ANIMAL VACCINES LIMITED | 19 janv. 2000 | Active | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |||
ELANCO ANIMAL VACCINES LIMITED | 01 juin 1994 | 01 août 1997 | Active | Accountant | Administrateur | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |
EDINGLEN LIMITED | 01 juin 1994 | 30 nov. 1994 | Active | Accountant | Administrateur | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | |
EDINGLEN LIMITED | 30 mars 1990 | 30 nov. 1994 | Active | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
VETBED (ANIMAL CARE) LIMITED | 22 oct. 1993 | 31 oct. 1994 | Active | Secrétaire | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | ||
GRAMPIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 30 mars 1990 | 12 mars 1993 | Dissoute | Secrétaire | 12 Brenfield Drive G44 3LT Glasgow Lanarkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0