LEGIST SECRETARIES LIMITED
Dirigeant de société
Nom | LEGIST SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 31 |
Total | 31 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
MEXX LIMITED | 23 mars 1993 | 01 juin 2007 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
OBEROI UK LIMITED | 08 oct. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London | |
POWELL MAIL ORDER LIMITED | 31 juil. 1996 | 07 avr. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
FCB NOMINEES LIMITED | 25 nov. 1994 | 23 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
DISASTER MASTER LIMITED | 20 sept. 2001 | 01 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
DISASTER LINE LIMITED | 03 févr. 1998 | 01 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
BELFOR UK LIMITED | 01 avr. 1994 | 01 févr. 2005 | Active | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
RELECTRONIC-REMECH LTD. | 23 oct. 2000 | 28 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
BELFOR PREVENTION LIMITED | 14 juil. 1998 | 28 janv. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
DELAVAN EUROPEAN MARKETING COMPANY (D E M CO) LIMITED | 23 oct. 1998 | 08 juil. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
DELAVAN LIMITED | 31 déc. 1996 | 08 juil. 2002 | Active | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
GOODRICH (GREAT BRITAIN) LIMITED. | 20 oct. 1995 | 08 juil. 2002 | Active | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
MAGNUM HUNT EXECUTIVE SEARCH LIMITED | 20 juil. 1995 | 15 févr. 2001 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
DDI HOLDINGS LIMITED | 18 mars 1999 | 03 déc. 1999 | Active | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
ST. JOHN'S INVESTMENT GROUP LIMITED | 01 janv. 1998 | 03 déc. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
LIDEX INTERNATIONAL LIMITED | 01 avr. 1997 | 03 déc. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London |
TODD-AO FILMATIC LIMITED | 30 avr. 1996 | 08 janv. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
DELUXE 142 LIMITED | 16 mars 1995 | 08 janv. 1999 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
FERMOR HESKETH TRADING LIMITED | 14 juin 1994 | 01 nov. 1998 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
DALROAD 1 PLC | 07 août 1996 | 31 juil. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
WRENBRIDGE (BRACKMILLS) LIMITED | 16 mai 1997 | 13 juil. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
CINRAM LOGISTICS UK LIMITED | 25 avr. 1997 | 30 mars 1998 | Liquidation | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
PARKGATE BOOKS LIMITED | 19 mars 1996 | 20 août 1997 | Dissoute | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
BELITHA PRESS LIMITED | 10 juil. 1995 | 20 août 1997 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
CASTLE HOWARD ARBORETUM TRUST | 05 janv. 1995 | 23 juin 1997 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
ANOVA DIGITAL LIMITED | 02 janv. 1997 | 03 janv. 1997 | Active | Administrateur | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
GAMA GROUP LIMITED | 18 févr. 1994 | 14 oct. 1996 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
C & C AGENCIES LIMITED | 14 mars 1996 | 01 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
CLEARVIEW INTELLIGENCE GROUP LIMITED | 23 nov. 1995 | 18 mars 1996 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC | 14 févr. 1995 | 14 févr. 1995 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
THALES MISSILE ELECTRONICS LIMITED | 19 déc. 1994 | 21 déc. 1994 | Active | Secrétaire | 4 John Carpenter Street EC4Y 0NH London |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0