Gavin MACKENZIE
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Gavin |
| Nom de famille | MACKENZIE |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 11 |
| Inactif | 2 |
| Démissionné | 19 |
| Total | 32 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERNESS AND CROMARTY FIRTH GREEN FREEPORT LIMITED | 04 juil. 2025 | Active | Administrateur | Old Perth Road Raigmore IV2 3JH Inverness Uhi House Scotland | Scotland | British | ||
| ANIMO VENTURES LIMITED | 05 janv. 2023 | Active | Administrateur | Hill Park IV2 4AL Inverness 1 Scotland | Scotland | British | ||
| AONGHUSA BUNUS LIMITED | 05 janv. 2023 | Active | Administrateur | Hill Park IV2 4AL Inverness 1 Scotland | Scotland | British | ||
| AONGHUSA LIMITED | 20 déc. 2022 | Active | Administrateur | Hill Park IV2 4AL Inverness 1 Scotland | Scotland | British | ||
| REGCOMMUNITY LIMITED | 16 sept. 2020 | Dissoute | Administrateur | Balvonie Avenue IV2 3RS Inverness 2 Scotland | Scotland | British | ||
| MEALLMORE LIMITED | 19 juin 2018 | Active | Administrateur | Cradlehall Business Park IV2 5GH Inverness Caulfield House | Scotland | British | ||
| GAVIN MACKENZIE LIMITED | 17 mars 2011 | Active | Administrateur | Hill Park IV2 4AL Inverness 1 Highland United Kingdom | Scotland | British | ||
| CS2010 LIMITED | 14 juin 2010 | Active | Administrateur | Hill Park IV2 4AL Inverness 1 Scotland | Scotland | British | ||
| DIGITAL FUNDING PARTNERSHIP (UK) LLP | 24 févr. 2010 | Dissoute | Membre de la LLP | Bught Drive IV3 5SR Inverness Inverness Ice Centre Highland | Scotland | |||
| ROCKFACE PROPERTY LIMITED | 23 avr. 2008 | Active | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | |||
| LITTLEJOHN'S RESTAURANTS (U.K.) LIMITED | 01 juil. 2003 | Active | Secrétaire | Hill Park IV2 4AL Inverness 1 Scotland | British | |||
| CALEDONIAN CINEMAS LIMITED | 01 juil. 2003 | Active | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | |||
| CALEDONIAN NIGHTCLUBS LIMITED | 01 juil. 2003 | Active | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | |||
| CAIRNSTAR LIMITED | 03 oct. 2001 | 15 sept. 2019 | Active | Administrateur | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | Scotland | British | |
| CALEDONIAN CINEMAS LIMITED | 01 juil. 2003 | 15 juil. 2019 | Active | Administrateur | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | Scotland | British | |
| CALEDONIAN NIGHTCLUBS LIMITED | 01 juil. 2003 | 15 juil. 2019 | Active | Administrateur | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | Scotland | British | |
| LITTLEJOHN'S RESTAURANTS (U.K.) LIMITED | 01 juil. 2003 | 14 juil. 2019 | Active | Administrateur | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | Scotland | British | |
| CAIRNSTAR LIMITED | 03 oct. 2001 | 15 juin 2018 | Active | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | ||
| HIGHLAND THEOLOGICAL COLLEGE | 03 janv. 2009 | 27 avr. 2015 | Active | Administrateur | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | Scotland | British | |
| SLIOCH LIMITED | 27 juil. 2005 | 24 juil. 2014 | Active | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | ||
| NMACK LIMITED | 16 févr. 2007 | 30 mars 2012 | Dissoute | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | ||
| EUROMOVEMENTS LIMITED | 14 déc. 2006 | 09 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 1 Hill Park IV2 4AL Inverness | British | ||
| TAYLOR CLARK LEISURE PLC | 14 nov. 2000 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Administrateur | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TC RESTAURANTS LIMITED | 01 avr. 1999 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Administrateur | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TC CINEMAS LIMITED | 01 avr. 1999 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Administrateur | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TC NIGHTCLUBS LIMITED | 01 avr. 1999 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Administrateur | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TC RESTAURANTS LIMITED | 23 janv. 1998 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TAYLOR CLARK LEISURE PLC | 23 janv. 1998 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TC CINEMAS LIMITED | 23 janv. 1998 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| TC NIGHTCLUBS LIMITED | 23 janv. 1998 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| YORK HOUSE (KENSINGTON) LIMITED | 01 avr. 1999 | 15 juin 1999 | Active | Administrateur | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British | ||
| YORK HOUSE (KENSINGTON) LIMITED | 23 janv. 1998 | 15 juin 1999 | Active | Secrétaire | 52 Stratherrick Gardens IV2 4LZ Inverness | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0