Graham Ronald MOORE
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Graham |
| Deuxième prénom | Ronald |
| Nom de famille | MOORE |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 2 |
| Inactif | 5 |
| Démissionné | 9 |
| Total | 16 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDG PROPERTIES (WM) LIMITED | 01 déc. 2008 | Active | Administrateur | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a Somerset | United Kingdom | British | ||
| WIGGINTON ESTATES LIMITED | 14 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Millfield House Mill Lane WS14 0DW Shenstone The Office Staffs England | British | |||
| WIGGINTON ESTATES LIMITED | 14 nov. 2008 | Dissoute | Administrateur | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | |||
| DDG PROPERTIES LIMITED | 22 janv. 2003 | Active | Administrateur | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a Avon United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| WODEN DEVELOPMENTS (WEST BROMWICH) LIMITED | 01 oct. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 124 Main Street Stonnall WS9 9DY Walsall Woodman Court West Midlands | British | |||
| WINCHESTER LEISURE LIMITED | 24 avr. 1997 | Dissoute | Secrétaire | Main Street Stonnall WS9 9DY Walsall Woodman Court 124 West Midlands | British | |||
| DORCHESTER TAVERNS LIMITED | 28 févr. 1997 | Dissoute | Secrétaire | Main Street Stonnall WS9 9DY Walsall Woodman Court 124 West Midlands | British | |||
| WIGGINTON DEVELOPMENTS LLP | 22 avr. 2009 | 05 avr. 2016 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a United Kingdom | United Kingdom | ||
| WODEN DEVELOPMENTS LIMITED | 09 sept. 1998 | 31 mai 2011 | Dissoute | Secrétaire | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a Avon United Kingdom | British | ||
| DORCHESTER LAND LIMITED | 12 déc. 2003 | 19 mai 2011 | Dissoute | Secrétaire | Royal Crescent BA1 2LT Bath 27a | British | ||
| TAMAR GROUP LIMITED | 02 févr. 2006 | 05 juin 2006 | Dissoute | Secrétaire | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| ANNESLEY DEVELOPMENTS LIMITED | 06 févr. 2006 | 23 mars 2006 | Dissoute | Secrétaire | Millfield House Mill Lane WS14 0DW Shenstone The Office Staffs England | British | ||
| NORBURY SPECIALIST CONTRACTS LTD. | 06 févr. 2006 | 01 mars 2006 | Dissoute | Secrétaire | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| NORTH PARK (UK) LIMITED | 16 avr. 2003 | 26 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| SOUTH HANDFORD DEVELOPMENT LIMITED | 22 juil. 1998 | 08 mai 2002 | Active | Secrétaire | Millfield House Mill Lane Shenstone WS14 0DW Lichfield Staffordshire | British | ||
| TAMAR (SELBY) LIMITED | 25 oct. 2001 | 06 nov. 2001 | Active | Secrétaire | Torrington House 75 Branston Road DE14 3BY Burton On Trent | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0