Stuart William YATES
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Stuart |
| Deuxième prénom | William |
| Nom de famille | YATES |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 12 |
| Démissionné | 35 |
| Total | 48 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREAK SCENE SOHO LIMITED | 09 mars 2018 | Dissoute | Administrateur | London Cornhill EC3V 3QQ London 73 United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| ROSONE LIMITED | 11 mai 2017 | Dissoute | Administrateur | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| INNOVATE POWER LIMITED | 12 janv. 2016 | Dissoute | Administrateur | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Buckinghamshire England | United Kingdom | British | ||
| ORRAN PARTNERS LIMITED | 14 juin 2013 | Active | Administrateur | Waterend Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| ENVIRONMENTAL FUEL SYSTEMS LIMITED | 11 août 2010 | Dissoute | Administrateur | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| FAB'S FAB LIMITED | 08 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | British | |||
| JACKSON LLOYD GROUP LIMITED | 23 oct. 2007 | Dissoute | Administrateur | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Buckinghamshire | United Kingdom | British | ||
| JACKSON LLOYD GROUP LIMITED | 23 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Buckinghamshire United Kingdom | British | |||
| JACKSON LLOYD HOLDINGS LIMITED | 23 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Cottage Buckinghamshire United Kingdom | British | |||
| JACKSON LLOYD HOLDINGS LIMITED | 23 oct. 2007 | Dissoute | Administrateur | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Cottage Buckinghamshire | United Kingdom | British | ||
| CAD'S BAD LIMITED | 01 oct. 2007 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | ||
| FAB'S FAB LIMITED | 01 oct. 2007 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | ||
| BRAVO INVESTMENTS LIMITED | 18 janv. 2007 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | ||
| SATEBA UK LIMITED | 01 sept. 2022 | 05 janv. 2026 | Active | Administrateur | Littlewell Lane Stanton By Dale DE7 4QW Ilkeston Derbyshire | United Kingdom | British | |
| SBC RAIL LIMITED | 01 sept. 2022 | 05 janv. 2026 | Active | Administrateur | Littlewell Lane Stanton By Dale DE7 4QW Ilkeston Derbyshire | United Kingdom | British | |
| TRACEY CONCRETE STANTON LIMITED | 15 août 2023 | 23 oct. 2023 | Active | Administrateur | Stanton By Dale DE7 4QW Ilkeston Littlewell Lane United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MOREGREEN ENERGY LIMITED | 11 juil. 2016 | 19 avr. 2017 | Active | Administrateur | Green Lane Bovingdon HP3 0LA Hemel Hempstead 71 England | United Kingdom | British | |
| INTELLIGENT TOYS LIMITED | 10 déc. 2003 | 16 déc. 2016 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | |
| MCCONNELL - ENERGY LIMITED | 01 mai 2015 | 14 déc. 2016 | Dissoute | Administrateur | Grange Gardens Farnham Common SL2 3HL Slough 14 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MPC CAPITAL LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 10 oct. 2007 | 09 août 2012 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Cottage Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | ||
| MPC PARTNERS LLP | 06 avr. 2004 | 09 août 2012 | Dissoute | Membre de la LLP | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Cottage Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | ||
| ALBEMARLE STREET (NOMINEES) LIMITED | 30 janv. 2008 | 20 sept. 2011 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | |
| TACTICA PREMIUM FINANCE LIMITED | 26 sept. 2007 | 15 août 2011 | Dissoute | Administrateur | c/o Mpc Albemarle Street W1S 4HA London 1 United Kingdom | England | British | |
| ALBEMARLE PRIVATE CAPITAL LIMITED | 25 mai 2007 | 15 juin 2011 | Active | Secrétaire | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Cottage Buckinghamshire United Kingdom | British | ||
| ALBEMARLE PRIVATE CAPITAL LIMITED | 25 mai 2007 | 15 juin 2011 | Active | Administrateur | Water End Stokenchurch HP14 3XQ High Wycombe Robin Hill Cottage Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| COUNTRYMAN POWER LIMITED | 09 juin 2005 | 25 mai 2011 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | |
| G & M POWER PLANT LIMITED | 23 oct. 2000 | 25 mai 2011 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | |
| MPC ACQUISITIONS 100 LTD | 13 janv. 2010 | 31 mars 2011 | Dissoute | Administrateur | 1 Albemarle Street W1S 4HA London Albemarle House United Kingdom | England | British | |
| MDC ACQUISITIONS 200 LTD | 13 janv. 2010 | 31 mars 2011 | Dissoute | Administrateur | 1 Albemarle Street W1S 4HA London Albemarle House United Kingdom | England | British | |
| RED HILL INVESTMENTS LTD | 13 janv. 2010 | 31 mars 2011 | Dissoute | Administrateur | 1 Albemarle Street W1S 4HA London Albemarle House United Kingdom | England | British | |
| JACKSON LLOYD LIMITED | 08 janv. 2008 | 30 sept. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | British | ||
| JACKSON LLOYD LIMITED | 01 oct. 2007 | 30 sept. 2010 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British | |
| COUNTRYMAN POWER LIMITED | 14 janv. 2008 | 12 mai 2010 | Dissoute | Secrétaire | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | British | ||
| G & M POWER PLANT LIMITED | 08 nov. 2007 | 12 mai 2010 | Dissoute | Secrétaire | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | British | ||
| THERMOPOL INTERNATIONAL LIMITED | 21 févr. 2005 | 31 janv. 2007 | Dissoute | Administrateur | 81 Gunterstone Road West Kensington W14 9BT London | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0