Deborah Jocelyn HOUGHTON
Personne physique
Titre | Ms |
---|---|
Prénom | Deborah |
Deuxième prénom | Jocelyn |
Nom de famille | HOUGHTON |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 18 |
Total | 20 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.M. PORTER LIMITED. | 01 oct. 2008 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
BURDETT CONSULTING LIMITED | 22 nov. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | |||
PLAYFORCE LIMITED | 28 févr. 2014 | 16 juin 2015 | Active | Finance Director | Administrateur | Pegasus Way Bowerhill SN12 6TR Melksham 1 Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British |
PFG HOLDINGS LIMITED | 28 févr. 2014 | 16 juin 2015 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Pegasus Way Bowerhill SN12 6TR Melksham 1 Wiltshire | United Kingdom | British |
NEWINCCO 1224 LIMITED | 28 févr. 2014 | 16 juin 2015 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Pegasus Way Bowerhill SN12 6TR Melksham 1 Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British |
ANDREW BROWNSWORD HOTELS LIMITED | 01 nov. 2012 | 30 déc. 2013 | Active | Director And Company Secretary | Administrateur | Queen Square BA1 2HA Bath 4 England | United Kingdom | British |
THE MANCHESTER ABODE LIMITED | 07 mars 2006 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
THE CHESTER ABODE LIMITED | 21 févr. 2006 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
THE COUNTY HOTEL CANTERBURY LIMITED | 04 mars 2005 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
ANDREW BROWNSWORD HOTELS LIMITED | 17 août 2004 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
MICHAEL CAINES LIMITED | 17 août 2004 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
THE ROYAL CLARENCE HOTEL LIMITED | 17 août 2004 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
THE ARTHOUSE GLASGOW LIMITED | 23 juil. 2004 | 30 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
CASTLE STREET MANAGEMENT LIMITED | 27 oct. 2008 | 20 déc. 2013 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | |
FOURSQUARE ASSOCIATES LIMITED | 14 sept. 2007 | 20 déc. 2013 | Dissoute | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
THE BATH PRIORY LIMITED | 17 août 2004 | 16 déc. 2013 | Active | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | ||
CULPEPER UK LIMITED | 01 avr. 2003 | 03 avr. 2008 | Dissoute | Chartered Accountant | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | |
BRUNSWICK PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 28 avr. 2002 | 08 sept. 2005 | Active | Chartered Accountant | Secrétaire | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | British | |
BRUNSWICK PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 17 août 2001 | 08 sept. 2005 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | United Kingdom | British |
M S L PROPERTY LIMITED | 17 mars 2000 | 20 déc. 2002 | Active | Accountant | Administrateur | 2 Tyning End BA2 6AN Bath | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0