WILLIAM PRICE & SONS LIMITED

WILLIAM PRICE & SONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILLIAM PRICE & SONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00203177
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILLIAM PRICE & SONS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova WILLIAM PRICE & SONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Shipton Mill
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILLIAM PRICE & SONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per WILLIAM PRICE & SONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Application for strike off 06/06/2018
    RES13

    Stato del capitale al 08 mag 2018

    • Capitale: GBP 10
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel capital redemption reserve 04/05/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Charles Garavan come amministratore in data 15 set 2016

    2 pagineTM01

    Nomina di David Roberts come segretario in data 20 apr 2016

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Charles Garavan come segretario in data 20 apr 2016

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 nov 2015

    Stato del capitale al 13 nov 2015

    • Capitale: GBP 100,300
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 nov 2014

    Stato del capitale al 18 nov 2014

    • Capitale: GBP 100,300
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 nov 2013

    Stato del capitale al 12 nov 2013

    • Capitale: GBP 100,300
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di WILLIAM PRICE & SONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBERTS, David
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Shipton Mill
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Shipton Mill
    Gloucestershire
    United Kingdom
    208788010001
    LISTER, John Richard Arkwright
    Shipton Mill
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Shipton Mill
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish18046460001
    BELLEINI, Brian John
    3 Bramley Way
    Whittington
    WS14 9SB Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    3 Bramley Way
    Whittington
    WS14 9SB Lichfield
    Staffordshire
    British6230250003
    GARAVAN, Charles
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    Segretario
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    Irish52207090001
    PRICE, Alan Geoffrey
    The Dell 29 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LN Birmingham
    Hereford & Worcester
    Segretario
    The Dell 29 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LN Birmingham
    Hereford & Worcester
    British18205830001
    BRIDSON, John
    18a Bridge Park
    Ivypark
    PL21 0AT Plymouth
    Devon
    Amministratore
    18a Bridge Park
    Ivypark
    PL21 0AT Plymouth
    Devon
    British47307550005
    CLARK, Matthew
    4 Adcroft Piece
    Stapleford
    CB2 5FD Cambridge
    Amministratore
    4 Adcroft Piece
    Stapleford
    CB2 5FD Cambridge
    British62828780002
    COWLING, Colin Richard, Director
    18 The Glade
    Escrick
    YO19 6JH York
    Amministratore
    18 The Glade
    Escrick
    YO19 6JH York
    United KingdomBritish96639130001
    GARAVAN, Charles
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    Amministratore
    Curragrean
    IRISH Galway
    Ireland
    IrelandIrish52207090001
    HELE, Susan Amanda
    Lilley Green Farm
    Lilley Green Road, Alvechurch
    B48 7HA Birmingham
    Amministratore
    Lilley Green Farm
    Lilley Green Road, Alvechurch
    B48 7HA Birmingham
    British75310510001
    JONES, David Eurfyl
    Greenacres 7 Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Greenacres 7 Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    British10978940002
    PRICE, Alan Geoffrey
    The Dell 29 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LN Birmingham
    Hereford & Worcester
    Amministratore
    The Dell 29 Cherry Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LN Birmingham
    Hereford & Worcester
    British18205830001
    PRICE, Jonathan
    14 The Crescent
    B92 0BP Hampton In Arden
    West Midlands
    Amministratore
    14 The Crescent
    B92 0BP Hampton In Arden
    West Midlands
    British111512800001
    PRICE, Martin Raymond
    Basse Croft
    Henley Road Claverdon
    CV35 8PS Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Basse Croft
    Henley Road Claverdon
    CV35 8PS Warwick
    Warwickshire
    British10978960001
    PRICE, Robin Mark Dodgson
    71 Barrowgate Road
    W4 4QS London
    Amministratore
    71 Barrowgate Road
    W4 4QS London
    EnglandBritish68496360002
    PRICE, Wilfred Barrie
    3 Chadwick Manor
    Chadwick End Knowle
    B93 0AT Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Chadwick Manor
    Chadwick End Knowle
    B93 0AT Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish6799190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WILLIAM PRICE & SONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr John Richard Arkwright Lister
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Shipton Mill
    England
    06 apr 2016
    Long Newnton
    GL8 8RP Tetbury
    Shipton Mill
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    WILLIAM PRICE & SONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 27 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as the former avonmor dairy and builders yard wolverhampton rd,walsall; t/nos WM463992 and SF110124. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1993
    Consegnato il 03 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The harvestime bakery and associated office workshop and parking facilities at rayleigh street hollyhedge road jessel road neale street and hollyhedge close walsall west midlands and goodwill of the business and all fixtures fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1993
    Consegnato il 02 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 29 mar 1993
    Consegnato il 02 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £240,491
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brother Limited
    Transazioni
    • 02 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 ago 1989
    Consegnato il 24 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land fronting to hollyhedge lane forming part of aides of nos. 35-35 (odd nos.) hollyhedge lane walsall t/n wm 341728 together with all buildings & fixtures floating charge over all moveable plans machinery, implements utensils furniture goods and equipment assigs goodwill (if any).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1987
    Consegnato il 27 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a piece of land being port of sites of nos. 53 and 69 jessep road and 23 to 29 (odd nos.) jessep road walsall west midlands floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment & assigns goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 ago 1986
    Consegnato il 03 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on the south west of neale street walsall west midlands t/n - wm 367099.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 apr 1984
    Consegnato il 06 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property, bodyshop, neale st., Walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 apr 1984
    Consegnato il 06 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H south side of margaret rd leicester title no: LT22134.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 20 mar 1984
    Consegnato il 22 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1981
    Consegnato il 30 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land having a frontage to hollyhedge lane, walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 dic 1980
    Consegnato il 08 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold 50 to 58 holly hedge lane walsall W.midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 dic 1980
    Consegnato il 08 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land garage workshops & office fronting to hollyhedge lane walsall W.midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 feb 1980
    Consegnato il 19 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 30,000
    Brevi particolari
    1. land and premises fronting neale street, walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • W B Price
    • A G Price
    • R a Price
    Transazioni
    • 19 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1979
    Consegnato il 10 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 37, jessel road, walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1979
    Consegnato il 10 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 39 and 41, jessel road walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1979
    Consegnato il 10 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 33 and 35 jessel road, walsall, west midlands. Title no sf 50260.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1979
    Consegnato il 10 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 31 jessel road walsall, west midlands title no sf 78141.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 lug 1979
    Consegnato il 01 ago 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold lands premises situate at 40 & 42 raleigh st walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1978
    Consegnato il 03 nov 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 36, raleigh street, walsall, west midlands. Title no wm 95494.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1978
    Consegnato il 03 nov 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises in raleigh street, walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1978
    Consegnato il 03 nov 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises in jessel road & no 51 jessel road, walsall, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 23 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0