DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED

DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01673252
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Griffin House, 135 High Street
    RH10 1DQ Crawley
    West Sussex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHECK TECHNOLOGY LIMITED10 dic 198210 dic 1982
    CHEQUE TECHNOLOGY LIMITED21 ott 198221 ott 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018

    3 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Rawlison Butler Nominees Limited come segretario in data 10 apr 2018

    1 pagineTM02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2016

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a Griffin House, 135 High Street Crawley West Sussex RH10 1DQ in data 21 apr 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Richard Michael Lee come amministratore in data 20 apr 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Rawlison Butler Nominees Limited come segretario in data 20 apr 2017

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sean Michael Marren come amministratore in data 20 apr 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2015

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Abogado Nominees Limited come segretario in data 25 ago 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ago 2016

    Stato del capitale al 23 ago 2016

    • Capitale: GBP 351,000
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Gregory Furness come amministratore in data 10 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dieter P Schilling come amministratore in data 10 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Sean Michael Marren come amministratore in data 10 ago 2016

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 lug 2015

    Stato del capitale al 15 lug 2015

    • Capitale: GBP 351,000
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2014

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEE, Richard Michael
    High Street
    RH10 1DQ Crawley
    Griffin House, 135
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    RH10 1DQ Crawley
    Griffin House, 135
    West Sussex
    United Kingdom
    CanadaBritish229743160001
    JOANES, Andrew
    20 Woodhall Drive
    SE21 7HJ London
    Segretario
    20 Woodhall Drive
    SE21 7HJ London
    British62023710001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario nominato
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    RAWLISON BUTLER NOMINEES LIMITED
    High Street
    RH10 1DQ Crawley
    Griffin House, 135
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    RH10 1DQ Crawley
    Griffin House, 135
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03520636
    229740770001
    BARNISKIS, Robert Martin
    6905 Rosemary Road
    Eden Prairie
    Minnestoa
    55346-2931
    Usa
    Amministratore
    6905 Rosemary Road
    Eden Prairie
    Minnestoa
    55346-2931
    Usa
    American68833080001
    FURNESS, Gregory
    6100 West 110th Street Drake St Nw
    Bloomington
    Delphax Technologies Inc
    Minnesota 55438
    United States
    Amministratore
    6100 West 110th Street Drake St Nw
    Bloomington
    Delphax Technologies Inc
    Minnesota 55438
    United States
    American125958870002
    GARRETT(III), Thomas Harris
    540 Wentworth Avenue West
    FOREIGN Mendota Heights 55118 2830 Usa
    Minnesota
    Amministratore
    540 Wentworth Avenue West
    FOREIGN Mendota Heights 55118 2830 Usa
    Minnesota
    American27992430002
    HERMAN, Jay
    8871 Cove Point Road
    Eden Prairie
    Minnesota 55347
    Usa
    Amministratore
    8871 Cove Point Road
    Eden Prairie
    Minnesota 55347
    Usa
    American27992440002
    JAGGARD, Ian John Sidney
    8 Ghyll Crescent
    RH13 6BG Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    8 Ghyll Crescent
    RH13 6BG Horsham
    West Sussex
    British27992450002
    JAGGARD, Ian
    7 Chichester Close
    LU5 4AG Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    7 Chichester Close
    LU5 4AG Dunstable
    Bedfordshire
    British27992450001
    MADDOCKS, Christopher Anthony
    26 Third Avenue
    BN14 9NZ Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    26 Third Avenue
    BN14 9NZ Worthing
    West Sussex
    British9937010001
    MARREN, Sean Michael
    Vector Pont
    Newton Road
    RH10 9AU Crawley
    1
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Vector Pont
    Newton Road
    RH10 9AU Crawley
    1
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish212196020001
    MATHIESEN, Jeffrey Scott
    13640 Duluth Drive
    Apple Valley
    Mn 55124
    Usa
    Amministratore
    13640 Duluth Drive
    Apple Valley
    Mn 55124
    Usa
    UsaAmerican100695000001
    REZNICK, Robert
    4331 West
    25th Street
    FOREIGN St Louis Park 55416
    Usa
    Amministratore
    4331 West
    25th Street
    FOREIGN St Louis Park 55416
    Usa
    American27992460001
    SCHILLING, Dieter P
    Lakeville
    55044
    17756 Ketchikan Trail
    Minnesota Usa
    Amministratore
    Lakeville
    55044
    17756 Ketchikan Trail
    Minnesota Usa
    American130617970001
    STEPHENSON, Paul William Berry
    818 Hidden Meadow Trail
    Eagan Minnesota 55123
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    818 Hidden Meadow Trail
    Eagan Minnesota 55123
    FOREIGN Usa
    British34888720002
    VICTOR, Oscar
    1620 Central Ne
    FOREIGN Minnesota 65413
    Usa
    Amministratore
    1620 Central Ne
    FOREIGN Minnesota 65413
    Usa
    Usa27992470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Richard Michael Lee
    135 High Street
    RH10 1DQ Crawley
    Griffin House
    West Sussex
    21 apr 2017
    135 High Street
    RH10 1DQ Crawley
    Griffin House
    West Sussex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Canada
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Delphax Technologies, Inc
    Whitewater Drive
    55344 Minnetonka
    Suite 10, 12301
    Minnesota
    United States
    06 apr 2016
    Whitewater Drive
    55344 Minnetonka
    Suite 10, 12301
    Minnesota
    United States
    No
    Forma giuridicaInc
    Paese di registrazioneUs Federal
    Autorità legaleMinneapolis
    Luogo di registrazioneMinnesota
    Numero di registrazione41-1392000
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DELPHAX TECHNOLOGIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 gen 2013
    Consegnato il 22 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Faunus Group International Inc (Fgi)
    Transazioni
    • 22 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 01 lug 2009
    Consegnato il 08 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re delphax technologies limited us dollar current account a/c no 87307855.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 07 dic 2007
    Consegnato il 12 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital investments plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Whitebox Delphax LTD
    Transazioni
    • 12 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 set 2007
    Consegnato il 28 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Financial Corporation Canada (The Secured Party)
    Transazioni
    • 28 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 feb 2005
    Consegnato il 02 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Letter of charge
    Creato il 21 mag 1987
    Consegnato il 09 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever subject to a limitation of £200,000
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re check technology limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 01 mag 1987
    Consegnato il 14 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the secured amounts (as defined in the terms of the charge)
    Brevi particolari
    The assets namely the debts the property and the remaining property together with all substitutions and replacements for and products thereof not consituting consumer goods and together with proceeds of any and all of the foregoing property (for further details please see M18/may 21/cf).
    Persone aventi diritto
    • Norwest Bank Minneapolis National Association
    Transazioni
    • 14 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0