ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02307783
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O AARON AND PARTNERS LLP
    5-7 Grosvenor Court Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Modifica dei dettagli di Fourth Holdings Limited come persona con controllo significativo il 27 set 2022

    5 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Forum St Paul's 33 Gutter Lane Second Floor London EC2V 8AS United Kingdom a 5-7 Grosvenor Court Foregate Street Chester Cheshire CH1 1HG in data 04 ott 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 set 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Stato del capitale al 20 set 2022

    • Capitale: GBP 0.96410
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium account 16/09/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per John Whitmarsh il 22 lug 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Clinton Anderson il 22 lug 2022

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Fourth Holdings Limited come persona con controllo significativo il 22 lug 2022

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 90 Long Acre Covent Garden London WC2E 9RA a Forum St Paul's 33 Gutter Lane Second Floor London EC2V 8AS in data 09 giu 2021

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di John Whitmarsh come amministratore in data 05 ott 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Clinton Anderson come amministratore in data 02 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Berthelsen come amministratore in data 31 dic 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Benjamin William Hood come amministratore in data 31 dic 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ago 2019 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANDERSON, Clinton
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    5-7 Grosvenor Court
    Cheshire
    Amministratore
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    5-7 Grosvenor Court
    Cheshire
    United StatesAmericanChief Executive Officer267294470001
    WHITMARSH, John
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    5-7 Grosvenor Court
    Cheshire
    Amministratore
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    5-7 Grosvenor Court
    Cheshire
    United StatesAmericanChief Financial Officer267294480001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Segretario
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    British41693730006
    O'SHAUGHNESSY, Lesley Annette
    86 Fernhill Road
    OX5 1RR Begbroke
    Oxfordshire
    Segretario
    86 Fernhill Road
    OX5 1RR Begbroke
    Oxfordshire
    British102851620001
    BERTHELSEN, Christian
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    Amministratore
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    EnglandDanishChief Technical Officer127022230002
    BROOKER, Geoffrey Alan
    2 Prestidge Place
    OX5 2XR Kidlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Prestidge Place
    OX5 2XR Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant/Finance D89868450002
    CUTHBERT, Edward Guy Thompson
    57 Hemley Road
    Orsett
    RM16 3DG Grays
    Essex
    Amministratore
    57 Hemley Road
    Orsett
    RM16 3DG Grays
    Essex
    EnglandBritishDirector58491370001
    FREEMAN, Graeme Gideon
    106 Kelham Hall Drive
    Wheatley
    OX33 1YB Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    106 Kelham Hall Drive
    Wheatley
    OX33 1YB Oxford
    Oxfordshire
    BritishSoftware56973700002
    GOLDBLATT, Stuart Mark
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    Amministratore
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    EnglandBritishChief Financial Officer160655200002
    GOODBODY, Keith David
    16 Cleveland Gardens
    Barnes
    SW13 0AG London
    Amministratore
    16 Cleveland Gardens
    Barnes
    SW13 0AG London
    BritishSoftware64423160001
    GRIBBLE, David
    7 Strouds Meadow
    Cold Ash
    RG16 9PQ Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    7 Strouds Meadow
    Cold Ash
    RG16 9PQ Thatcham
    Berkshire
    BritishConsultant6553610001
    HERBERT, Russell
    Sheephouse Cottage
    Stepping Stone Lane
    GL6 6RX Painswick
    Gloucestershire
    Amministratore
    Sheephouse Cottage
    Stepping Stone Lane
    GL6 6RX Painswick
    Gloucestershire
    BritishManagement Consultant57912870003
    HOOD, Benjamin William
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    Amministratore
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    EnglandBritishChief Executive159402370002
    HOYLE, Christopher Michael
    Little Chippers
    Merton
    OX6 0NF Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    Little Chippers
    Merton
    OX6 0NF Bicester
    Oxfordshire
    BritishTechnical Director54528960002
    LAYZELL, Stuart Paul
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    United Kingdom
    Amministratore
    Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9RA London
    90
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone157984010001
    LILLEY, Derek
    Pinfold House
    Pinfold Lane Marthall
    WA16 7SN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Pinfold House
    Pinfold Lane Marthall
    WA16 7SN Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director12475750002
    LILLEY, Sharon Edwina
    Pinfold House
    Pinfold Lane Marthall
    WA16 7SN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Pinfold House
    Pinfold Lane Marthall
    WA16 7SN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector22518500002
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritishDirector41693730006
    O'SHAUGHNESSY, Anthony
    86 Fernhill Road
    Begbroke
    OX5 1RR Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    86 Fernhill Road
    Begbroke
    OX5 1RR Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishComputer Programmer24813320001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Suite 650
    3440 Preston Ridge Road
    GA 30005 Alpharetta
    Hotschedules
    United States
    Amministratore
    Suite 650
    3440 Preston Ridge Road
    GA 30005 Alpharetta
    Hotschedules
    United States
    United StatesBritishCfo261857010001
    SALTERS, Richard Mark
    4 Norton Gate
    Kings Norton
    B38 8DQ Birmingham
    Amministratore
    4 Norton Gate
    Kings Norton
    B38 8DQ Birmingham
    BritishSales And Marketing Director81993430001
    TRIVETT, Trevor Edward
    9 Green Farm
    Adderbury
    OX17 3PD Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    9 Green Farm
    Adderbury
    OX17 3PD Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishGeneral Manager6553600001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    5-7 Grosvenor Court
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    Aaron & Partners Llp
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    5-7 Grosvenor Court
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    Aaron & Partners Llp
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaUk Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04098237
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 07 set 2018
    Consegnato il 12 set 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Please see instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ab Private Credit Investors Llc
    Transazioni
    • 12 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 ago 2015
    Consegnato il 18 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Part lower ground floor 90 long acre london leasehold. Part second floor 90 long acre london leasehold. Second floor greenway house tytherington business park macclesfield cheshire leasehold.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ab Private Credit Investors Llc as Security Agent
    Transazioni
    • 18 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 mar 2011
    Consegnato il 26 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 mar 2011
    Consegnato il 25 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eci Ventures Nominees Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2010
    Consegnato il 16 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 dic 1994
    Consegnato il 03 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 mag 1990
    Consegnato il 21 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 giu 2023Data prevista di scioglimento
    27 set 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Janette Loiuse Chillery-Belcher
    5-7 Grosvenor Court
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    Cheshire
    Praticante
    5-7 Grosvenor Court
    Foregate Street
    CH1 1HG Chester
    Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0