JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED

JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02747910
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JARVIS STREAMLINE LIMITED05 lug 199905 lug 1999
    STREAMLINE HOLDINGS LIMITED17 dic 199217 dic 1992
    INTERCEDE 996 LIMITED16 set 199216 set 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 16 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2011

    Stato del capitale al 07 gen 2011

    • Capitale: GBP 6,211,593.3
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    9 pagine363a

    Bilancio redatto al 02 apr 2007

    14 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    17 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    24 pagine395

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    17 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 mar 2004

    18 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Segretario
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish116740230002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    BATEMAN, Andrew
    34 Heath Close
    RG41 2PG Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    34 Heath Close
    RG41 2PG Wokingham
    Berkshire
    British24432680002
    BURTON, Ernest Walter
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    Segretario
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    British11389700001
    BUTTERY, Alison Tracey
    9 Cornish Court
    16 Bridlington Road
    N9 7RS London
    Segretario
    9 Cornish Court
    16 Bridlington Road
    N9 7RS London
    British61671200001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    ALDRED, Duncan
    Little Timbers Village Road
    TW20 8UF Thorpe
    Surrey
    Amministratore
    Little Timbers Village Road
    TW20 8UF Thorpe
    Surrey
    British34751970001
    BREEZE, Stevan William
    The Hamlet Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Hamlet Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British82679240001
    BUCKNALL, David John
    Barn End Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Barn End Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish2832240001
    BURTON, Ernest Walter
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    15 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    British11389700001
    CUNNINGHAM, Anthony
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135811090001
    DELANEY, Arnold
    18 Rue Phalsbourg
    75017 Paris
    FOREIGN France
    Amministratore
    18 Rue Phalsbourg
    75017 Paris
    FOREIGN France
    British66115970002
    DOYLE, Robert John
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    British79420210002
    EVANS, David Clark
    Lyle House
    67 Marsham Way
    SL9 8AW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lyle House
    67 Marsham Way
    SL9 8AW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish102876290001
    FERNANDEZ, Fernando
    Urbanizacion Soto De Camarena
    Sector A-47
    Chalet 47 Sector A
    Betera Valencia
    Spain
    Amministratore
    Urbanizacion Soto De Camarena
    Sector A-47
    Chalet 47 Sector A
    Betera Valencia
    Spain
    Spanish33280470001
    FLOATE, Ernst
    17 Ludlow Road
    Ealing
    W5 1NX London
    Amministratore
    17 Ludlow Road
    Ealing
    W5 1NX London
    British31983560001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Amministratore
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritish73774260004
    HOOD, Katherine Jane
    16 Gledhow Gardens
    SW5 0AY London
    Amministratore
    16 Gledhow Gardens
    SW5 0AY London
    American/French16419110001
    HYDE, Kevin Oliver
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    Amministratore
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    British66509100002
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Amministratore
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritish146249130001
    LATHAM, Michael, Sir
    508 Hood House Dolphin Square
    SW1V 3LX London
    Amministratore
    508 Hood House Dolphin Square
    SW1V 3LX London
    United KingdomBritish50879560002
    LEECH, David Ernest
    Ridgewood Springfield Lane
    Colgate
    RH12 4TA Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Ridgewood Springfield Lane
    Colgate
    RH12 4TA Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish36303610003
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    MOAYEDI, Paris
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish2646590001
    PIRRET, Gordon Maxwell, Mr.
    Bradwell Hall
    CM0 7HX Bradwell On Sea
    Essex
    Amministratore
    Bradwell Hall
    CM0 7HX Bradwell On Sea
    Essex
    EnglandBritish30161610003
    PLUMLEY, Xavier Alexander
    Holly Cottage
    Hill Farm Road
    SL6 0HA Taplow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Cottage
    Hill Farm Road
    SL6 0HA Taplow
    Buckinghamshire
    British51554040001
    PRATAP, Davendra
    2 Arosa Road
    Richmond Bridge
    TW1 2TL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    2 Arosa Road
    Richmond Bridge
    TW1 2TL Twickenham
    Middlesex
    British73125050001
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Amministratore
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritish53806830002
    REEVES, Barbara
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    British900004670001
    RIGBY, Bryan
    Cluny 61 Penn Road
    HP9 2LW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cluny 61 Penn Road
    HP9 2LW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish115143400001
    SIMPSON, Terence Colin Frank
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    British34093540001
    TAMINIAU, Cyril
    Beekstraat 36b
    5673 As Nuenen
    Netherlands
    Amministratore
    Beekstraat 36b
    5673 As Nuenen
    Netherlands
    Dutch33372840001

    JARVIS TRAFFIC SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 lug 2006
    Consegnato il 08 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture
    Creato il 17 gen 1996
    Consegnato il 05 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under each of the senior finance documents or any other documents as defined in this debenture
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co. Limited, (The "Security Agent") as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders (as Defined)
    Transazioni
    • 05 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 1993
    Consegnato il 18 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under each or any of the senior finance documents as defined in this debenture
    Brevi particolari
    See doc ref M102 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co. Limited (The "Security Agent")Lenders (as Defined)as Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transazioni
    • 18 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0