LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED

LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03103621
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MABLAW 331 LIMITED19 set 199519 set 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagineLIQ14

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    14 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 set 2018

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 set 2017

    13 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Freeths Llp Routeco Office Park Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ England a Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth Leicestershire LE17 5FB in data 04 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    9 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 16 set 2016

    LRESEX

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 20 Bentley Priory Mansion House Drive Stanmore HA7 3FB

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 20 Bentley Priory Mansion House Drive Stanmore HA7 3FB

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 61 Nascot Wood Road Watford WD17 4SJ a C/O Freeths Llp Routeco Office Park Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ in data 03 ago 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Silbury Court 420 Silbury Boulevard Central Milton Keynes Buckinghamshire MK9 2AF a 61 Nascot Wood Road Watford WD17 4SJ in data 20 gen 2016

    2 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 29 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2015

    Stato del capitale al 01 giu 2015

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2013 al 29 dic 2013

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2013 al 30 dic 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2014

    Stato del capitale al 26 giu 2014

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Gareth Thomas come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gareth Thomas come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NORTH, Clifford Douglas Robson, Dr
    61 Nascot Wood Road
    WD17 4SJ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    61 Nascot Wood Road
    WD17 4SJ Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChemical Engineer24150370001
    THOMAS, Gareth
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    BritishSales Manager24150380002
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    CRAWLEY, John Henry
    81 The Grove
    BR4 9LA West Wickham
    Kent
    Amministratore
    81 The Grove
    BR4 9LA West Wickham
    Kent
    EnglandBritishGeneral Manager45868090001
    THOMAS, Gareth
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Norbury Avenue
    WD24 4PJ Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishSales Manager24150380002
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    MABLAW NOMINEES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303350001

    LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 set 2009
    Consegnato il 23 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gareth Thomas
    Transazioni
    • 23 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 08 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 apr 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on the remainder of company's property
    Creato il 14 mar 2000
    Consegnato il 15 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the agreement or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other trade debts and floating charge on proceeds of other trade debts.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 15 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2000
    Consegnato il 16 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dr Clifford Douglas Robson North and Gareth Thomas
    Transazioni
    • 16 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 25 feb 2000
    Consegnato il 07 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000 being all monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter (as defined)
    Brevi particolari
    Beamax calibrator pc 106 and accessories per order lps/97/0776. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dr Clifford Douglas Robson North, Gareth Thomas and Namulas Pension Trustees Limited Astrustees of the Northom Limited Retirement Benefit Scheme
    Transazioni
    • 07 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 24 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    The plant machnery chattels or other machinery or other equipment set out in the schedule hereto :-negretti & zambra M2236 serial no A442. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 08 nov 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LITTLEBROOK POWER SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 set 2016Inizio della liquidazione
    19 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Richard Buttriss
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    Praticante
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    Richard Frank Simms
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire
    Praticante
    Alma Park Woodway Lane
    Claybrooke Parva
    LE17 5FB Lutterworth
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0