KINGSWAY MACHINING UK LIMITED

KINGSWAY MACHINING UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKINGSWAY MACHINING UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04067989
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KINGSWAY MACHINING UK LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova KINGSWAY MACHINING UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KINGSWAY MACHINING UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KINGSWAY PRECISION LIMITED08 set 200008 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di KINGSWAY MACHINING UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per KINGSWAY MACHINING UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 08 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 set 2013

    Stato del capitale al 25 set 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Barry Bernard come amministratore in data 02 ago 2013

    1 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Bilancio annuale redatto al 08 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    Nomina di Mr John Peter Reece come amministratore in data 01 dic 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roger David Anderton come amministratore in data 01 dic 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Philip John Kite come amministratore in data 01 dic 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Philip John Kite come segretario in data 01 dic 2012

    1 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SH in data 06 dic 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Steven Norman Simpson come segretario in data 01 dic 2012

    1 pagineTM02

    Stato del capitale al 23 nov 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG02

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Stato del capitale al 07 set 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Chi sono gli amministratori di KINGSWAY MACHINING UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KITE, Philip John
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Segretario
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    174185780001
    ANDERTON, Roger David
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    United KingdomBritishDirector99166030001
    KITE, Philip John
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    United KingdomBritishDirector166586060001
    REECE, John Peter
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    United KingdomBritishDirector10546590006
    SIMPSON, Steven Norman
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    EnglandBritishCh'Td Accountant49838890001
    BERNARD, Peter Barry
    Washing Well House 3 Front Street
    Whickham
    NE16 4HF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    Washing Well House 3 Front Street
    Whickham
    NE16 4HF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishDirector19362840002
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Segretario
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    BritishAccountant47328860003
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Segretario
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    BritishAccountant47328860003
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    SIMPSON, Steven Norman
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    Segretario
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishChartered Accountant49838890001
    BERNARD, Peter Barry
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Wincomblee Road
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    England
    United KingdomBritishEngineer19362840002
    DITCHBURN, David
    30 Harton Rise
    NE34 6DY South Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    30 Harton Rise
    NE34 6DY South Shields
    Tyne & Wear
    BritishEngineer71920040001
    REED, Robert
    26 St Andrews Drive
    NE9 6JT Low Fell
    Tyne & Wear
    Amministratore
    26 St Andrews Drive
    NE9 6JT Low Fell
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishEngineer112010820001
    THOMPSON, Christopher Scott
    Flat 1 Ashgill House
    Clayton Road Jesmond
    NE2 1TL Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Flat 1 Ashgill House
    Clayton Road Jesmond
    NE2 1TL Newcastle Upon Tyne
    BritishEngineer42840520003
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    KINGSWAY MACHINING UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 30 giu 2005
    Consegnato il 19 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 19 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus letter of set-off dated 07TH october 2004
    Creato il 07 ott 2004
    Consegnato il 14 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 14 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 16 set 2002
    Consegnato il 20 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2000
    Consegnato il 02 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0