ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04333841 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
- (9999) /
Dove si trova ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HYDREX LIMITED | 07 mar 2002 | 07 mar 2002 |
| INGLEBY (1479) LIMITED | 04 dic 2001 | 04 dic 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 30 giu 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Carl Mark D'ammassa il 04 dic 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan James Jordan come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Wood come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Wood come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
legacy | 35 pagine | MG01 | ||||||||||
Nomina di Mr Carl Mark D'ammassa come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Simcox come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 18 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 128(4) | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AMMASSA, Carl Mark | Amministratore | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | United Kingdom | British | 147037660007 | |||||
| JORDAN, Alan James | Amministratore | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | England | Irish | 150320720001 | |||||
| SEYMOUR, Paul Richard | Segretario | 14 Campanula Drive Meadow Brook NP10 9JG Rogerstone Newport | British | 75293670002 | ||||||
| WOOD, Andrew Simon | Segretario | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | 33951380003 | ||||||
| WOOD, Andrew Simon | Segretario | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | 33951380003 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| ADDIS, Jonathan Peter | Amministratore | Park Hill B13 8DS Birmingham 98 West Midlands United Kingdom | England | British | 260439420001 | |||||
| DAVIES, Brian Thomas | Amministratore | Woodbridge Rockvilla Lane Beachley Road NP6 2DR Chepstow Gwent | United Kingdom | British | 39854170001 | |||||
| GALLOWAY, David Allistair | Amministratore | Moat House Chapel Lane PO20 8QG West Wittering West Sussex | England | British | 180591130001 | |||||
| HUNTER, Richard James Martin | Amministratore | 2 Tirlemont Road CR2 6DS South Croydon | United Kingdom | British | 94346370001 | |||||
| LEWIS, Alan Stuart | Amministratore | Farleigh Road Backwell BS48 3PE Bristol Southfield Farm North Somerset United Kingdom | England | British | 139548580001 | |||||
| PAYNE, Alan Douglas | Amministratore | 112 Northfield Road Kings Norton B30 1JG Birmingham West Midlands | British | 74345940001 | ||||||
| ROGERS, Doug Ernest | Amministratore | Kiln House 5 Kiln Lane Dickens Heath Village B90 1SF Solihull West Midlands | British | 109970170001 | ||||||
| SEYMOUR, Paul Richard | Amministratore | 14 Campanula Drive Meadow Brook NP10 9JG Rogerstone Newport | British | 75293670002 | ||||||
| SIMCOX, Andrew James | Amministratore | Ashley Drive South Ashley Heath BH24 2JP Ringwood 53 Hampshire United Kingdom | England | British | 41023640002 | |||||
| WOOD, Andrew Simon | Amministratore | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | 33951380003 | |||||
| WOOD, Andrew Simon | Amministratore | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | 33951380003 | |||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 24 giu 2010 Consegnato il 08 lug 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 mar 2006 Consegnato il 23 mar 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 03 mar 2005 Consegnato il 17 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002 | Creato il 06 mag 2003 Consegnato il 09 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The words "and as furuther amended by way of a supplemental agreement dated 6 may 2003 shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002 | Creato il 21 feb 2003 Consegnato il 13 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The following amendments shall be made to the debenture the figure "2009" shall be inserted in place of the figure "2008" the words "amended by way of a side letter produced by osborne clarke dated 20 february 2003" shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor" the words "the third investor loan notes" shall be inserted after the words "the second investor loan notes" in the definition of "loan notes" the words "the third investor loan notes instrument" shall be inserted after the words "the second investor loan note instrument" in the definition of "loan notes instruments"the following new definitions shall be inserted "the third investor loan notes" means the loan notes constituted by the third investor loan notes instrument "the third investor loan note agreement" means the instrument to be entered into by the company pursuant to clause 3.4 of the investment agreement and pursuant to which £1,000,000 of fixed rate 8.8%-8% secured loan notes 2009 save as amended above the terms of the debenture shall remain full force and effect. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 mar 2002 Consegnato il 20 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman policy | Creato il 12 mar 2002 Consegnato il 20 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns the policy and all sums assured by it and all bonuses and benefitsand all right title and interest in and to the policy :- andrew simcox norwich union pol.no. 7739697EN. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 mar 2002 Consegnato il 20 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0