GCSC HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GCSC HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04408352 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GCSC HOLDINGS LIMITED?
- Attività di società holding agricole (64201) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova GCSC HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Merlin House Brunel Road Theale RG7 4AB Reading Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GCSC HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AMENITY HOLDINGS LIMITED | 23 mag 2002 | 23 mag 2002 |
| FOCALPEARL LIMITED | 03 apr 2002 | 03 apr 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GCSC HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per GCSC HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Overdene House 49 Church Street Theale Reading Berkshire RG7 5BX England a Merlin House Brunel Road Theale Reading Berkshire RG7 4AB in data 04 nov 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di 2020 Holdings Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Smart il 14 ott 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Carl Richard Crome il 14 ott 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Elizabeth Ann Hayman il 14 ott 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Elizabeth Hayman il 14 ott 2021 | 1 pagine | CH03 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Elizabeth Ann Hayman il 14 ott 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Merlin House Brunel Road Theale Reading Berkshire RG7 4AB England a Overdene House 49 Church Street Theale Reading Berkshire RG7 5BX in data 14 ott 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Elizabeth Mcguire come segretario in data 16 set 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020 | 8 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Overdene House 49 Church Street Theale Reading Berkshire RG7 5BX a Merlin House Brunel Road Theale Reading Berkshire RG7 4AB in data 09 apr 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di 2020 Holdings Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Mcguire il 09 lug 2019 | 1 pagine | CH03 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Elizabeth Ann Mcguire il 09 lug 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2020 con aggiornamenti | 8 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 8 pagine | AA | ||
Notifica di 2020 Holdings Limited come persona con controllo significativo il 27 feb 2020 | 4 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Carl Crome come persona con controllo significativo il 27 feb 2020 | 3 pagine | PSC07 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2019 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 044083520003 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Chi sono gli amministratori di GCSC HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYMAN, Elizabeth | Segretario | Brunel Road Theale RG7 4AB Reading Merlin House Berkshire England | British | 111497680004 | ||||||
| CROME, Carl Richard | Amministratore | Brunel Road Theale RG7 4AB Reading Merlin House Berkshire England | England | British | 38377020005 | |||||
| HAYMAN, Elizabeth Ann | Amministratore | Brunel Road Theale RG7 4AB Reading Merlin House Berkshire England | England | British | 147766630008 | |||||
| SMART, John | Amministratore | Brunel Road Theale RG7 4AB Reading Merlin House Berkshire England | United Kingdom | British | 156631900001 | |||||
| ANDREWS, Martin Richard | Segretario | Ravensworth Cottage Ravensworth Road Mortimer RG7 3UD Reading Berkshire | British | 55830730001 | ||||||
| CROME, Helen | Segretario | 49 Church Street Theale RG7 5BX Reading Overdene House Berkshire United Kingdom | 158983570001 | |||||||
| DLUGIEWICZ, Christopher Richard | Segretario | 5 May Park Calcot RG31 7RU Reading Berkshire | British | 66784780001 | ||||||
| MCGUIRE, Elizabeth | Segretario | Reading The Company's Registered Office Berkshire England | 208946440001 | |||||||
| MONTAGUE, Yvonne | Segretario | 10 Westfield Drive KT23 3NU Great Bookham Surrey | British | 87206990001 | ||||||
| WRIGHT, Alexander Lee | Segretario | 19 Hagley Road RG2 0DN Reading Berkshire | British | 70319560001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ASHWORTH, Stuart | Amministratore | 36 Richmond Road EX8 2NA Exmouth Devon | British | 61741410002 | ||||||
| CROME, Helen Louise | Amministratore | Rose Cottage Frilsham Hermitage RG18 9XQ Thatcham 1 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 172369240001 | |||||
| ERIKSSON, Hakan Gustaf | Amministratore | 59240 Vadstena Hedvig Eleonorasgata 3 Sweden | Sweden | Swedish | 172369820001 | |||||
| FLANAGAN, Stephen Mark | Amministratore | Mulsford Lane Worthenbury LL13 0AP Wrexham No 1 Queensford Clwyd Wales | Wales | British | 252134920001 | |||||
| HAINES, Gary Stanley | Amministratore | Tintagel Court Eynesbury PE19 2RZ St Neots 12 Cambridgeshire England | British | 130267370001 | ||||||
| LLOYD, Geoffrey Cyril | Amministratore | 49 Church Street Theale RG7 5BX Reading Overdene House Berkshire England | United Kingdom | British | 19146700003 | |||||
| MARTIN, Nicholas | Amministratore | 49 Church Street Theale RG7 5BX Reading Overdene House Berkshire England | United Kingdom | British | 156630710001 | |||||
| SULLIVAN, Gregory Mark | Amministratore | Shalford Dairy Wasing Estate RG7 4NB Aldermaston Berkshire | United Kingdom | Australian | 83276600001 | |||||
| WILTON, Mark | Amministratore | 49 Church Street Theale RG7 5BX Reading Overdene House Berkshire England | United Kingdom | British | 118460140001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GCSC HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Holdings Limited | 27 feb 2020 | 49 Church Street Theale RG7 5BX Reading Overdene House Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Carl Crome | 06 apr 2016 | Cheiveley RG20 8RQ Newbury 9 Orchard End Berkshire England | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
GCSC HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 28 mag 2013 Consegnato il 10 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including the land and buildings specified in section 2 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all fixed plant and machinery from time to time in or on any such land and buildings.. All patents, patent applications, trade marks, trade names, registered designs, copyrights, knowhow, and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits (including royalties fees and other income deriving from the same) now owned or at any time hereafter to be owned by the company.. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 giu 2010 Consegnato il 29 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture | Creato il 01 dic 2004 Consegnato il 14 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0