KBC BECKENHAM LIMITED

KBC BECKENHAM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKBC BECKENHAM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06341889
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KBC BECKENHAM LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KBC BECKENHAM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor, 2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KBC BECKENHAM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per KBC BECKENHAM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Burwood Place London W2 2UT England a 6th Floor, 2 Kingdom Street London W2 6BD in data 14 ago 2023

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Oliver Loh come amministratore in data 12 mag 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    2 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 063418890007, creata il 31 dic 2020

    32 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    17 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 063418890006, creata il 20 ott 2020

    4 pagineMR01

    Nomina di Mr Simon Oliver Loh come amministratore in data 06 feb 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Peter David Edward Gibson come amministratore in data 28 ott 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2016 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 268 Bath Road Slough SL1 4DX a 1 Burwood Place London W2 2UT in data 14 ott 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Alan Douglas Pepper come amministratore in data 09 set 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di KBC BECKENHAM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORRIS, Richard
    2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    6th Floor,
    England
    Amministratore
    2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    6th Floor,
    England
    EnglandBritish190653350001
    ALEXANDER, Paul
    c/o C/O Serviced Office Group
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Segretario
    c/o C/O Serviced Office Group
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183163730001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Segretario
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Segretario
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    185429200001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Fleet House
    8-12 New Bridge Street
    EC4V 6AL London
    Segretario
    Fleet House
    8-12 New Bridge Street
    EC4V 6AL London
    152163970002
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    CORPET, Antoine
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    Amministratore
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    French131276650001
    GIBSON, Peter David Edward
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Amministratore
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Amministratore
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KINGSHOTT, Michael James
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Amministratore
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    United KingdomBritish83713020001
    LOH, Simon Oliver
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    Amministratore
    Burwood Place
    W2 2UT London
    1
    England
    United KingdomBritish197301770002
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Amministratore
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    PETRIE, Roderick Mckenzie
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    Amministratore
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    ScotlandBritish1246700004
    ROWBOTTOM, Alex James
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    British135706810001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    c/o C/O Serviced Office Group
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Amministratore
    c/o C/O Serviced Office Group
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    EnglandBritish154659960001
    TASCHLER, Jeffery
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    Amministratore
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    United States135708370001
    WAKELIN, James David
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    Amministratore
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    British92221010001
    WASHINGTON, Robert Francis
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Amministratore
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Australian120776550001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KBC BECKENHAM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Consort Property Holdings Limited
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    06 apr 2016
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    KBC BECKENHAM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 dic 2020
    Consegnato il 18 gen 2021
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Genesis Finance Sa Rl
    Transazioni
    • 18 gen 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 ott 2020
    Consegnato il 27 ott 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pathway Finance Sarl
    Transazioni
    • 27 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    County house, 221 to 241 beckenham road, beckenham, kent t/no SGL19222. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. County house 221 to 241 beckenham road, beckenham, kent t/no SGL19222 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2012
    Consegnato il 28 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Persone aventi diritto
    • West Register Number 2 Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 2007
    Consegnato il 12 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 221-241 beckenham road beckenham t/n SGL19222. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 set 2007
    Consegnato il 03 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0