MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED: Executivos
Visão geral
Nome da empresa | MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 02426459 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Quem são os diretores de MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretário | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom |
| 270129230001 | ||||||||||
FORSTER, Jonathan David | Diretor | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire | United Kingdom | British | Accountant | 101812460002 | ||||||||
RUSSELL, Claire Tytherleigh | Diretor | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire | England | British | Lawyer | 105433380001 | ||||||||
YOUNG, Wayne Paul | Diretor | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 264531200001 | ||||||||
CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Secretário | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire | 198551320001 | |||||||||||
FOX, Jacqueline Elizabeth | Secretário | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
GILLEN, Seamus Joseph | Secretário | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||||||
MORRISON, John | Secretário | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | Secretary | 1500260013 | |||||||||
SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Secretário | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||||||
TURNER, David Charles | Secretário | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
ALDRED, Andrew Charles | Diretor | 4 Stanford Way Walton S42 7NH Chesterfield Derbyshire | British | Company Director | 32078000001 | |||||||||
ANDERSON, Mark Stephen | Diretor | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | Finance Director | 122463830003 | ||||||||
BARN, Alistair Melville | Diretor | 34 Hay Street PH1 5HS Perth Perthshire | British | Director | 1087370001 | |||||||||
CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Diretor | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 203580340001 | ||||||||
CROSON, Roger Archibald | Diretor | Belfit House 18 Nethermoor Road Wingerworth S42 6LJ Chesterfield Derbyshire England | British | Managing Director | 4350003 | |||||||||
FIRTH, Patrick | Diretor | The Cottage High Street PE28 0AB Ellington Huntingdon Cambs | British | Solicitor | 85034900001 | |||||||||
GILLESPIE, Kenneth | Diretor | 15 Craigs Bank EH12 8HD Edinburgh | England | British | Director | 77321980001 | ||||||||
HAMPSON, Michael David | Diretor | Anglian House Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Cambs | British | Company Director | 105084640001 | |||||||||
HEATHERSHAW, Peter Anthony | Diretor | 1 Limecroft View Wingerworth S42 6NR Chesterfield Derbyshire | British | Director | 20068550001 | |||||||||
HOWELL, Keith Martin | Diretor | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | Finance Director | 1499960006 | |||||||||
JEFFS, David John | Diretor | 17 Old Mill Lane Clifford LS23 6LE Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 3812460001 | ||||||||
JEFFS, David John | Diretor | 17 Old Mill Lane Clifford LS23 6LE Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 3812460001 | ||||||||
LE LORRAIN, Michael Robert | Diretor | Orchard House 3 Lea Brooks Close PE28 2RA Warboys Cambridgeshire | England | British | Director | 93716830003 | ||||||||
LOWE, Richard Alexander | Diretor | Cherry Tree 29 The View Alwoodley LS17 7NF Leeds West Yorkshire | British | Director | 32078010001 | |||||||||
MORRISON, Alexander Fraser | Diretor | Wester House 4 Wester Coates Gardens EH12 5LT Edinburgh Lothian | British | Director Of Companies | 4330001 | |||||||||
MORRISON, John | Diretor | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | Secretary | 1500260013 | |||||||||
NILSSON, Lars Ingvar | Diretor | Stora Fiskaregaten 9e S 222 24 FOREIGN Lund Sweden | Swedish | Director | 76837160001 | |||||||||
O'DELL, Robert James | Diretor | 12 Wensley Grove HG2 8AH Harrogate North Yorkshire | British | Company Director Quantity Surv | 6337720001 | |||||||||
RUSSELL, Claire Tytherleigh | Diretor | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Lawyer | 105433380001 | ||||||||
SALT, Anthony Charles | Diretor | Sepycoe Farm Longford DE6 3DR Ashbourne Derbyshire | British | Commercial Director | 34136380001 | |||||||||
TALLANT, Kenneth | Diretor | Brambles, 9 The Park Mayfield DE6 2HT Ashbourne Derby | England | British | Quantity Surveyor | 124187000001 | ||||||||
TAYLOR, Brian | Diretor | 29 Station Road Castle Donington DE74 2NJ Derby | British | Company Director | 34136880001 | |||||||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Diretor | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | Company Secretary | 135181230001 | ||||||||
WALSH, Stephen | Diretor | 589 London Road Davenham CW9 8LN Northwich Cheshire | England | British | Director | 60529360002 | ||||||||
WARRACK, Anne Victoria Mary | Diretor | The White Cottage 153 Bridge Street, Whddon SG8 5SP Royston Herts | United Kingdom | British | Company Secretary | 123157220001 |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0