David Stephen THOMAS-WALLS
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • David Stephen THOMAS-WALLS

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeDavid
    Segundo NomeStephen
    Último NomeTHOMAS-WALLS
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo4
    Inativo4
    Renunciado9
    Total17

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    MAXIMUS MOTORSPORT LIMITED06/04/2021AtivaDiretor
    Grendon Road
    Polesworth
    B78 1NS Tamworth
    C/O Black Fox Advisers Limited
    England
    EnglandBritish
    UNBOWND LIMITED03/11/2020AtivaDiretor
    Fletchers Business Centre, Grendon Road
    Polesworth
    B78 1NS Tamworth
    C/O Black Fox Advisers Limited
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish
    UNCOMMON LIMITED01/10/2020LiquidaçãoDiretor
    Foregate Street
    WR1 1EE Worcester
    40-41
    EnglandBritish
    SPENCER GARDNER DICKINS TRUSTEES LIMITED11/07/2018DissolvidaDiretor
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3 Coventry Innovation Village
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish
    MIRADA PERFORMANCE PRODUCTS LIMITED03/06/2015DissolvidaDiretor
    Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SPENCER GARDNER DICKINS AUDIT LLP06/05/2009AtivaMembro designado da LLP
    3 Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    England
    SPENCER GARDNER DICKINS FINANCIAL SERVICES LLP03/04/2007DissolvidaMembro designado da LLP
    3 Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    England
    SPENCER GARDNER DICKINS LLP02/03/2007DissolvidaMembro designado da LLP
    3 Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    England
    CARB'N-OFF LIMITED14/07/202208/08/2025AtivaDiretor
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3 Coventry Innovation Village
    England
    EnglandBritish
    BIN FACTORY OUTLET LTD18/08/202326/04/2024AtivaDiretor
    Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3
    England
    EnglandBritish
    SPENCER GARDNER DICKINS FINANCIAL SERVICES LIMITED06/05/201115/04/2024AtivaDiretor
    3 Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    EnglandBritish
    SPENCER GARDNER DICKINS LIMITED04/04/200712/04/2024AtivaDiretor
    3 Coventry Innovation Village
    CV1 2TL Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish
    BIN FACTORY OUTLET LTD15/12/202215/08/2023AtivaDiretor
    Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3
    England
    EnglandBritish
    FULL CIRCLE GRAPHIX LIMITED17/08/202104/02/2022AtivaDiretor
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3 Coventry Innovation Village
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish
    THE 1189808 FOUNDATION05/05/202004/02/2021AtivaDiretor
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3 Coventry Innovation Village
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    STORM WASTE SYSTEMS LIMITED20/06/201130/01/2017AtivaDiretor
    Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish
    PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP01/07/200527/02/2007AtivaMembro da LLP
    3 Coventry Innovation Village
    Cheetah Road
    CV1 2TL Coventry
    England

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0