Jane Caroline Grantham SMITHARD
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Jane Caroline Grantham SMITHARD

    Pessoa Física

    TítuloMs
    Primeiro NomeJane
    Segundo NomeCaroline Grantham
    Último NomeSMITHARD
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo1
    Inativo1
    Renunciado12
    Total14

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    ENTCORP MARIGALANTE UK LIMITED08/10/2019DissolvidaDirectorDiretor
    22 - 30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    England
    United KingdomBritish
    24 SUTHERLAND STREET LTD12/05/2016AtivaLawyerDiretor
    SW1V 4LA London
    24 Sutherland Street
    England
    United KingdomBritish
    ENTCO HOLDING BERLIN B.V.23/06/202130/06/2022Convertida/FechadaGroup CounselDiretor
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    BORLAND (UK) LIMITED18/02/202130/06/2022DissolvidaChief Legal Officer And Group General CounselDiretor
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn 22-30
    Berkshire
    United KingdomBritish
    BORLAND (HOLDING) UK LIMITED18/02/202130/06/2022DissolvidaChief Legal Officer, Group General CounselDiretor
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn 22-30
    Berkshire
    United KingdomBritish
    MICRO FOCUS FOREIGN HOLDCO LTD17/10/201930/06/2022AtivaDirectorDiretor
    22 - 30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    England
    United KingdomBritish
    AUTONOMY SYSTEMS LIMITED17/10/201930/06/2022AtivaDirectorDiretor
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish
    MICRO FOCUS SITULA HOLDING LTD17/10/201930/06/2022AtivaDirectorDiretor
    22 - 30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    England
    United KingdomBritish
    MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD20/03/201930/06/2022AtivaGroup General Counsel & Company SecretaryDiretor
    22 - 30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish
    MICRO FOCUS GROUP LIMITED02/11/201830/06/2022AtivaGroup General Counsel And Company SecretaryDiretor
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn 22-30
    United KingdomBritish
    ROCKET SOFTWARE AMC UK LTD26/03/201830/06/2022AtivaGroup General Counsel And Company SecretaryDiretor
    The Lawn
    22-30 Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish
    SERENA HOLDINGS02/05/201630/06/2022LiquidaçãoDirectorDiretor
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn, 22 - 30
    England
    United KingdomBritish
    MERANT HOLDINGS02/05/201630/06/2022LiquidaçãoDirectorDiretor
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn, 22 - 30
    England
    United KingdomBritish
    SERENA SOFTWARE EUROPE LIMITED02/05/201630/06/2022LiquidaçãoDirectorDiretor
    Old Bath Road
    RG14 1QN Newbury
    The Lawn, 22 - 30
    England
    United KingdomBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0