John BOYLE
Pessoa Física
Título | Mr |
---|---|
Primeiro Nome | John |
Último Nome | BOYLE |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 4 |
Inativo | 20 |
Renunciado | 38 |
Total | 62 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMILTON HINDLEY PROPERTIES LTD | 02/08/2021 | Dissolvida | Director | Diretor | 176 St Vincent Street G2 5SG Glasgow The Beacon Scotland | United Kingdom | British | |
HCP HASI LLP | 01/07/2014 | Ativa | Membro designado da LLP | Mercantile Buildings, Suite 10 53 Bothwell Street G2 6TS Glasgow C/O Hkip Llp Scotland | Scotland | |||
NETIDME LTD | 10/12/2012 | Dissolvida | Director | Diretor | Nasmyth Avenue G75 0QR East Kilbride Nasmyth Building Scotland | Scotland | British | |
SIMPLE ORDERING LIMITED | 12/06/2012 | Dissolvida | Company Director | Diretor | Unit A1 Dolphin Way BN43 6NZ Shoreham By Sea West Sussex | Scotland | British | |
WGS (HAMILTON) LLP | 20/04/2012 | Dissolvida | Membro designado da LLP | 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building United Kingdom | Scotland | |||
GSO HAMILTON CIP LIMITED | 20/09/2011 | Dissolvida | Director | Diretor | The Beacon St. Vincent Street G2 5SG Glasgow 176 Scotland | Scotland | British | |
GLASGOW SOUTH ORBITAL (HAMILTON) LIMITED | 14/09/2011 | Dissolvida | Director | Diretor | King's Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 | Scotland | British | |
HAMILTON RUTHERGLEN LIMITED | 06/09/2011 | Dissolvida | None | Diretor | Ground Floor 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building United Kingdom | Scotland | British | |
HAMILTON GSO LLP | 26/08/2011 | Dissolvida | Membro da LLP | 20 Renfield Street G2 5AP Glasgow Sterling House United Kingdom | Scotland | |||
HAMILTON ORBITAL HOUSE LLP | 14/09/2010 | Dissolvida | Membro designado da LLP | 3rd Floor, 20 Renfield Street G2 5AP Glasgow Sterling House Scotland | Scotland | |||
KELVINHAUGH LLP | 01/10/2007 | Dissolvida | Membro designado da LLP | c/o The Hamilton Portfolio 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building Scotland | Scotland | |||
NEWBIGGING FARM LLP | 30/09/2007 | Dissolvida | Membro da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | |||
HAMILTON ROAD DEVELOPMENTS LLP | 27/07/2007 | Dissolvida | Membro designado da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | |||
NEWLANDSMUIR LLP | 01/07/2007 | Dissolvida | Membro da LLP | Kingsborough Gardens G12 9NH Glasgow 5 | Scotland | |||
WESTBOURNE PORTFOLIO LIMITED | 26/04/2007 | Ativa | Director | Diretor | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | British | |
THE HOLIDAY PLANNER LTD | 02/03/2007 | Dissolvida | Director | Diretor | 44 Westbourne Gardens Kelvinside G12 9XQ Glasgow | British | ||
ARDOCH LLP | 03/11/2006 | Dissolvida | Membro designado da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 | Scotland | |||
ZOOM AIRLINES LIMITED | 29/08/2006 | Dissolvida | Chairman | Diretor | 44 Westbourne Gardens Kelvinside G12 9XQ Glasgow | British | ||
MARYHILL DEVELOPMENTS LLP | 07/07/2005 | Dissolvida | Membro da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 | Scotland | |||
BARRANCE FARM LLP | 14/04/2005 | Dissolvida | Membro designado da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | |||
ELLIOT STREET DEVELOPMENTS LIMITED | 05/06/2001 | Dissolvida | Director | Diretor | Kingsborough Gardens G12 9XQ Kelvinside 5 Glasgow | British | ||
THE HAMILTON PORTFOLIO LIMITED | 18/05/1999 | Dissolvida | Entrepeneur | Diretor | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | British | |
02650075 LIMITED | 26/04/1993 | Liquidação | Company Director | Diretor | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | Scotland | British | |
BLACKBURN PRINT LIMITED | Ativa | Company Director | Diretor | 55 Kenilworth Square Rathmines Dublin 6 Eire | British | |||
HCP HIGH YIELD COMMERCIAL PROPERTY LLP | 14/05/2013 | 23/02/2022 | Dissolvida | Membro da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 Scotland | Scotland | ||
ALTIA-ABM GROUP LIMITED | 24/08/2017 | 23/11/2020 | Ativa | Director | Diretor | 107-111 Fleet Street EC4A 2AB London C/O Johnston Carmichael England | United Kingdom | British |
ABM INTELLIGENCE LIMITED | 09/08/2016 | 23/11/2020 | Ativa | None | Diretor | West Regent Street G2 2RQ Glasgow 146 Scotland United Kingdom | United Kingdom | British |
XALTIA TECHNOLOGY LIMITED | 28/05/2014 | 23/11/2020 | Ativa | Company Director | Diretor | Altia-Abm Nottingham Science & Technology Park NG7 2RL Nottingham Bell House | United Kingdom | British |
ALTIA SOLUTIONS LIMITED | 31/12/2012 | 23/11/2020 | Ativa | Company Director | Diretor | West Regent Street G2 2RQ Glasgow 146 Scotland | United Kingdom | British |
BLACKFORD MEDIA LLP | 23/09/2004 | 05/04/2020 | Dissolvida | Membro da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | ||
OAK HOTELS LLP | 03/04/2008 | 22/11/2019 | Dissolvida | Membro designado da LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | ||
HINDLEY ENDURA LLP | 17/09/2014 | 08/08/2018 | Dissolvida | Membro da LLP | Aurora Building 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Hamilton Portfolio United Kingdom | Scotland | ||
THE HAMILTON PORTFOLIO PARTNERSHIP LLP | 19/03/2013 | 31/03/2017 | Ativa | Membro designado da LLP | 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building United Kingdom | Scotland | ||
HAMILTON CAPITAL PARTNERS LLP | 16/03/2010 | 24/03/2017 | Ativa | Membro da LLP | 176 St. Vincent Street G2 5SG Glasgow The Beacon | Scotland | ||
HAMCAP REDHEUGHS LLP | 27/01/2015 | 03/02/2017 | Dissolvida | Membro designado da LLP | 176 St. Vincent Street G2 5SG Glasgow The Beacon | Scotland |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0