Jayne Katherine BURRELL
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Jayne Katherine BURRELL

    Pessoa Física

    TítuloMiss
    Primeiro NomeJayne
    Segundo NomeKatherine
    Último NomeBURRELL
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo1
    Renunciado23
    Total24

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    JUVIN-ESSENCE LIMITED14/04/2016DissolvidaCompany DirectorDiretor
    Sandpiper Court
    Chester Business Park
    CH4 9QZ Chester
    Office Village
    Cheshire
    England
    EnglandBritish
    IS PHARMACEUTICALS LIMITED05/01/201509/12/2024AtivaDirectorDiretor
    Lakeside
    Chester Business Park
    CH4 9QT Chester
    Eden House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ACORUS THERAPEUTICS LIMITED02/01/201509/12/2024AtivaDirectorDiretor
    Lakeside
    Chester Business Park
    CH4 9QT Chester
    Eden House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SINCLAIR PHARMA HOLDINGS LIMITED02/01/201509/12/2024AtivaDirectorDiretor
    Floor
    Whitfield Court 30-32 Whitfield Street
    W1T 2RQ London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED02/01/201509/12/2024AtivaDirectorDiretor
    Lakeside
    Chester Business Park
    CH4 9QT Chester
    Eden House
    England
    EnglandBritish
    SINCLAIR PHARMA MANAGEMENT LIMITED02/01/201509/12/2024AtivaDirectorDiretor
    Whitfield Court
    30-32 Whitfield Street
    W1T 2RQ London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish
    IS PHARMA LTD02/01/201509/12/2024AtivaBritishDiretor
    Lakeside
    Chester Business Park
    CH4 9QT Chester
    Eden House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ICELAND IN ICELAND LIMITED05/10/201212/12/2014DissolvidaSolicitorDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Iceland Foods Limited
    Clwyd
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ICELAND FROZEN FOODS LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    RAMSGATE FLAT MANAGEMENT COMPANY LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    CT ICE ACQUISITIONS LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    KINGDOM INLAND TRADING LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    BEECH HOUSE DEESIDE LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND FOODS HOLDINGS LIMITED19/03/201212/12/2014DissolvidaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    BEJAM GROUP LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND FOODSTORES LIMITED19/03/201212/12/2014DissolvidaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    BURGUNDY LIMITED19/03/201212/12/2014DissolvidaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND OVERSEAS LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND GROUP LIMITED19/03/201212/12/2014DissolvidaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND (NOMINEES) LIMITED19/03/201212/12/2014DissolvidaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    DEESIDE STORAGE LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    EnglandBritish
    BEJAM FREEZER FOOD CENTRES LIMITED19/03/201212/12/2014AtivaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish
    ICELAND LIMITED19/03/201212/12/2014DissolvidaCompany SecretaryDiretor
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0