• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Mark Anthony EMLICK

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeMark
    Segundo NomeAnthony
    Último NomeEMLICK
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo4
    Inativo31
    Renunciado90
    Total125

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    LIFF CARE HOME LIMITED04/09/2020AtivaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    DS RESIDENTIAL LIMITED25/11/2019DissolvidaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENOCH SQUARE LIMITED15/05/2019DissolvidaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    BRUNTSFIELD BRASSERIE LICENSE LTD14/06/2016DissolvidaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    DUNEDIN INVESTMENTS LIMITED16/10/2015DissolvidaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    DS MUSSELBURGH LTD27/03/2015DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CONSENSUS 5475 LLP04/11/2013DissolvidaMembro designado da LLP
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    Scotland
    ME&AM INVESTMENTS LIMITED03/12/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    JIM ALLISON EDITING LIMITED02/11/2012DissolvidaDiretor
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL EDINBURGH LTD02/10/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CCPE - RIVERSIDE LTD03/09/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    DLL GEORGE IV BRIDGE LTD29/08/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    27&29 PALMERSTON PLACE LTD31/07/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    EVOLVE COUTURE LTD16/07/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CCPE RETAIL AGENTS LTD13/07/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CCPE - MEDIA LTD13/07/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    CCPE NORTHAMPTON SOLAR LTD11/06/2012DissolvidaDiretor
    Sunbury Street
    EH4 3BU Edinburgh
    22
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CCPE BRISTOL SOLAR LTD11/06/2012DissolvidaDiretor
    Sunbury Street
    EH4 3BU Edinburgh
    22
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CCPE NEWPORT SOLAR LTD11/06/2012DissolvidaDiretor
    Sunbury Street
    EH4 3BU Edinburgh
    22
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CCPE MILLENIUM SOLAR LTD11/06/2012DissolvidaDiretor
    Sunbury Street
    EH4 3BU Edinburgh
    22
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ADOREUM MIAMI UK LIMITED02/04/2012DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL LAND LTD.06/09/2011DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ACCESS ENERGY MICRO WIND LTD05/07/2011DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    Scotland
    ScotlandBritish
    ACCESS ENERGY (GP2) LTD02/06/2011DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    ACCESS ENERGY (GP1) LTD26/05/2011DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CONSENSUS PARK MANAGEMENT LTD26/05/2011DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL GROUP LIMITED26/05/2011AtivaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    ACCESS ENERGY FOUNDER PARTNER LTD26/05/2011DissolvidaDiretor
    Charlotte Square
    EH2 4HQ Edinburgh
    45
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    41 CHARLOTTE SQUARE LIMITED10/03/2011DissolvidaDiretor
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3,
    ScotlandBritish
    CONSENSUS CAPITAL HOLDINGS LIMITED29/09/2010AtivaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    DUNEDIN LIFECARE LIMITED28/07/2010DissolvidaDiretor
    42 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4HQ
    ScotlandBritish
    CORPORATE EMPLOYEE BENEFITS LIMITED28/07/2010DissolvidaDiretor
    42 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4HQ
    ScotlandBritish
    ENSCO 291 LIMITED18/12/2009DissolvidaDiretor
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower
    UkBritish
    FORRES STREET LIMITED15/06/2009DissolvidaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish
    GATEWAY GLASGOW LTD10/06/2009AtivaDiretor
    Craigmillar Park
    EH16 5NE Edinburgh
    10
    Scotland
    ScotlandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0