Mark Anthony EMLICK
Pessoa Física
| Título | Mr |
|---|---|
| Primeiro Nome | Mark |
| Segundo Nome | Anthony |
| Último Nome | EMLICK |
| Data de Nascimento | |
| É Executivo Corporativo | Não |
| Nomeações | |
| Ativo | 4 |
| Inativo | 31 |
| Renunciado | 90 |
| Total | 125 |
Nomeações
| Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFF CARE HOME LIMITED | 04/09/2020 | Ativa | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| DS RESIDENTIAL LIMITED | 25/11/2019 | Dissolvida | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| ENOCH SQUARE LIMITED | 15/05/2019 | Dissolvida | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| BRUNTSFIELD BRASSERIE LICENSE LTD | 14/06/2016 | Dissolvida | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 United Kingdom | Scotland | British | ||
| DUNEDIN INVESTMENTS LIMITED | 16/10/2015 | Dissolvida | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| DS MUSSELBURGH LTD | 27/03/2015 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| CONSENSUS 5475 LLP | 04/11/2013 | Dissolvida | Membro designado da LLP | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | |||
| ME&AM INVESTMENTS LIMITED | 03/12/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| JIM ALLISON EDITING LIMITED | 02/11/2012 | Dissolvida | Diretor | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | Scotland | British | ||
| CONSENSUS CAPITAL EDINBURGH LTD | 02/10/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| CCPE - RIVERSIDE LTD | 03/09/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| DLL GEORGE IV BRIDGE LTD | 29/08/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| 27&29 PALMERSTON PLACE LTD | 31/07/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| EVOLVE COUTURE LTD | 16/07/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| CCPE RETAIL AGENTS LTD | 13/07/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| CCPE - MEDIA LTD | 13/07/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| CCPE NORTHAMPTON SOLAR LTD | 11/06/2012 | Dissolvida | Diretor | Sunbury Street EH4 3BU Edinburgh 22 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CCPE BRISTOL SOLAR LTD | 11/06/2012 | Dissolvida | Diretor | Sunbury Street EH4 3BU Edinburgh 22 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CCPE NEWPORT SOLAR LTD | 11/06/2012 | Dissolvida | Diretor | Sunbury Street EH4 3BU Edinburgh 22 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CCPE MILLENIUM SOLAR LTD | 11/06/2012 | Dissolvida | Diretor | Sunbury Street EH4 3BU Edinburgh 22 United Kingdom | Scotland | British | ||
| ADOREUM MIAMI UK LIMITED | 02/04/2012 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CONSENSUS CAPITAL LAND LTD. | 06/09/2011 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | British | ||
| ACCESS ENERGY MICRO WIND LTD | 05/07/2011 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 Scotland | Scotland | British | ||
| ACCESS ENERGY (GP2) LTD | 02/06/2011 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | British | ||
| ACCESS ENERGY (GP1) LTD | 26/05/2011 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CONSENSUS PARK MANAGEMENT LTD | 26/05/2011 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | British | ||
| CONSENSUS CAPITAL GROUP LIMITED | 26/05/2011 | Ativa | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| ACCESS ENERGY FOUNDER PARTNER LTD | 26/05/2011 | Dissolvida | Diretor | Charlotte Square EH2 4HQ Edinburgh 45 United Kingdom | Scotland | British | ||
| 41 CHARLOTTE SQUARE LIMITED | 10/03/2011 | Dissolvida | Diretor | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | Scotland | British | ||
| CONSENSUS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 29/09/2010 | Ativa | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| DUNEDIN LIFECARE LIMITED | 28/07/2010 | Dissolvida | Diretor | 42 Charlotte Square Edinburgh EH2 4HQ | Scotland | British | ||
| CORPORATE EMPLOYEE BENEFITS LIMITED | 28/07/2010 | Dissolvida | Diretor | 42 Charlotte Square Edinburgh EH2 4HQ | Scotland | British | ||
| ENSCO 291 LIMITED | 18/12/2009 | Dissolvida | Diretor | 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower | Uk | British | ||
| FORRES STREET LIMITED | 15/06/2009 | Dissolvida | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | ||
| GATEWAY GLASGOW LTD | 10/06/2009 | Ativa | Diretor | Craigmillar Park EH16 5NE Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0