• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Scott Keelor ANDERSON

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeScott
    Segundo NomeKeelor
    Último NomeANDERSON
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo13
    Inativo4
    Renunciado31
    Total48

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    PRIDE (SERP) LTD08/05/2024AtivaDirectorDiretor
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Second Floor, Eagle Court 2
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE IAMP MICROGRID LIMITED06/12/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE PRIVATE NETWORKS HOLDCO LIMITED07/06/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE BTM OPERATIONAL ASSETS LIMITED22/05/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE DIGITAL SERVICES LIMITED27/01/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED20/12/2022AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE HV ELECTRICITY ASSETS LIMITED13/10/2022AtivaAccountantDiretor
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE BTM HOLDCO LIMITED12/10/2022AtivaAccountantDiretor
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE DE SOLAR HOLDCO LIMITED22/06/2022AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE CONTRACTING GROUP LIMITED25/03/2021AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE HEAT NETWORKS LIMITED26/10/2020AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE UTILITY SOLUTIONS LIMITED26/10/2020AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE HEAT NETWORKS (BATTERSEA) LIMITED26/10/2020AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    EALING LIGHTING LIMITED24/11/2016DissolvidaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    ISLINGTON LIGHTING LIMITED24/11/2016DissolvidaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SEC HIGHWAY LIGHTING DORSET LIMITED24/11/2016DissolvidaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    DORSET LIGHTING LIMITED24/11/2016DissolvidaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    NEWMILNS SNOW AND SPORTS COMPLEX08/11/202231/01/2025AtivaHead Of FinanceDiretor
    High Street
    KA16 9EB Newmilns
    35
    Ayrshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    SOURCE EV UK LIMITED06/10/202210/09/2024AtivaAccountantDiretor
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SOURCE EV LIMITED05/08/202210/09/2024AtivaDirectorDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE EWERBY SOLAR LIMITED24/06/202324/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE SOUTHERY SOLAR LIMITED22/06/202324/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE EGGBOROUGH LIMITED16/06/202324/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE EWERBY SOLAR HOLDCO LIMITED16/06/202324/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    BY-PASS FARM SOLAR LIMITED16/12/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE FIDDLERS FERRY BATTERY LIMITED14/10/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE FERRYBRIDGE BATTERY LIMITED11/10/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE BATTERY MONK FRYSTON LIMITED03/08/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE MUSKHAM SOLAR LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE BATTERY LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE SOLAR LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE KNAPTHORPE SOLAR LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE FOXHOLES SOLAR LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE POWER LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE SGT LIMITED25/05/202224/11/2023AtivaAccountantDiretor
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0