• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Andrew James FROUD

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeAndrew
    Segundo NomeJames
    Último NomeFROUD
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo1
    Inativo3
    Renunciado22
    Total26

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    MY PERFECT COLLAGEN LIMITED11/09/2015DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    EnglandBritish
    ALICSUR UK LIMITED19/07/2013DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish
    PALMER CLARK LIMITED29/03/2004DissolvidaSecretário
    Mulberry House
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    RLF PROPERTIES LIMITED11/02/1999AtivaDiretor
    Bishopton Lane
    Bishopton
    CV37 9QY Stratford-Upon-Avon
    Bruce Lodge
    England
    EnglandBritish
    PALMER CLARK LIMITED30/09/201501/10/2020AtivaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    EnglandBritish
    MFA 3 LIMITED01/10/201630/09/2020AtivaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    United Kingdom
    EnglandBritish
    MULBERRY FROUD ASSOCIATES LIMITED17/01/201130/09/2020AtivaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish
    MULBERRY PORTFOLIOS LIMITED01/05/201030/09/2020DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish
    SKYVAPES LTD08/04/201518/08/2020DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    EnglandBritish
    COSMEDIC SURGICAL LIMITED07/12/201508/05/2019DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    EnglandBritish
    JOHN CRONIN SALES LIMITED07/09/201701/10/2017DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    EnglandBritish
    JOHN CRONIN SALES LIMITED04/11/201501/07/2016DissolvidaDiretor
    Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    51
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    THE SUSAN HERBERT PORTFOLIO LIMITED17/07/201301/11/2013AtivaDiretor
    Mulberry House
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold On Stour
    The Studio
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    COTSWOLD FUDGE CO. LIMITED12/03/200815/05/2012AtivaDiretor
    Mulberry House
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PALMER CLARK LIMITED11/01/201131/01/2011DissolvidaDiretor
    The Chapel Chapel Lane
    Newbold On Stour
    CV37 8TY Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    MULBERRY PORTFOLIOS LIMITED12/06/200901/12/2009DissolvidaDiretor
    Mulberry House
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    RETAIL ELITE LTD09/11/200701/09/2009DissolvidaDiretor
    Mulberry House
    Brook Lane
    CV37 8UA Newbold On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    CHRIS FORMAN LIMITED01/10/200401/09/2006DissolvidaSecretário
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    EUROPEAN RETAIL ENGINEERING LIMITED16/10/200128/02/2006AtivaDiretor
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    MFSF LIMITED01/09/200323/08/2005AtivaDiretor
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    SUSSEX HOUSE (GLENILLA ROAD) LIMITED04/03/200331/03/2005AtivaSecretário
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    INSPECTION LINK LIMITED01/11/200117/09/2004DissolvidaSecretário
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    FOUR CORNERS TRADING COMPANY LIMITED02/01/200101/10/2003LiquidaçãoSecretário
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    KEYSTROKE TYPESETTING & GRAPHIC DESIGN LIMITED02/01/200215/05/2003DissolvidaSecretário
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    QUADRACO LIMITED18/11/200121/11/2002DissolvidaSecretário
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British
    INSPECTION LINK LIMITED03/10/200001/11/2001DissolvidaDiretor
    Fintree House
    Rookery Lane
    CV37 8TZ Newbold On Stour
    Warwickshire
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0