• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Alistair James WILLEY

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeAlistair
    Segundo NomeJames
    Último NomeWILLEY
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo1
    Renunciado29
    Total30

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    RUBY PROPERTIES (ENFIELD) LIMITED14/09/2018DissolvidaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS & SPENCER SIMPLY FOODS LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    RUBY PROPERTIES (TUNBRIDGE) LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    BUSYEXPORT LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    RUBY PROPERTIES (THORNCLIFFE) LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    RUBY PROPERTIES (LONG EATON) LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER PROPERTY HOLDINGS LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    AMETHYST LEASING (PROPERTIES) LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    RUBY PROPERTIES (HARDWICK) LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER CHESTER LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    RUBY PROPERTIES (CUMBERNAULD) LIMITED14/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER (BRADFORD) LIMITED13/09/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (WARRINGTON GEMINI STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER (PROPERTY INVESTMENTS) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (CHESTER STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (KINGSTON-ON-THAMES STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER (PROPERTY VENTURES) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (KINGSTON-ON-THAMES SATELLITE STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    SIMPLY FOOD (PROPERTY INVESTMENTS)31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (GLASGOW SAUCHIEHALL STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (PUDSEY STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (HEDGE END STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    AMETHYST LEASING (HOLDINGS) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (CHESTER SATELLITE STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019DissolvidaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (PARMAN HOUSE KINGSTON STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER SHARED SERVICES LIMITED31/03/201827/06/2019DissolvidaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (BROOKLANDS STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (KENSINGTON STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    MARKS AND SPENCER 2005 (FIFE ROAD KINGSTON STORE) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish
    SIMPLY FOOD (PROPERTY VENTURES) LIMITED31/03/201827/06/2019AtivaAccountantDiretor
    Waterside House
    35 North Wharf Road
    W2 1NW London
    EnglandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0