Patrice Jean-Philippe HUGON
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Patrice Jean-Philippe HUGON

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomePatrice
    Segundo NomeJean-Philippe
    Último NomeHUGON
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo8
    Inativo6
    Renunciado28
    Total42

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    66 PAH LLP05/12/2024AtivaMembro designado da LLP
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    England
    SYLCORP HOLDING LTD06/03/2024AtivaDirectorDiretor
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    EnglandFrench
    BEECHCROFT COM1 LTD01/04/2021AtivaDirectorDiretor
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    United Kingdom
    EnglandFrench
    BEECHCROFT R1 LTD01/04/2021AtivaDirectorDiretor
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    EnglandFrench
    66 KAPKOH LTD23/12/2019AtivaDirectorDiretor
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    EnglandFrench
    66 MANAGEMENT LTD30/11/2017DissolvidaAccountantDiretor
    Buckingham Palace Road
    SW1W 0RP London
    91-93, Vectryss Ltd
    United Kingdom
    EnglandFrench
    VIF LIMITED17/05/2016DissolvidaAccountantDiretor
    78/79 New Bond Street
    W1S 1RZ London
    4th Floor
    United Kingdom
    United KingdomFrench
    VIARENTIS LTD15/10/2014DissolvidaFinance DirectorDiretor
    Hopton Road
    SW16 2ER London
    12 Russell Court
    United Kingdom
    United KingdomFrench
    SURREY DESIGN COLLECTION LTD07/09/2009DissolvidaAccountantDiretor
    Carlingford Gardens
    CR4 2AT Mitcham
    29
    Surrey
    United Kingdom
    UkFrench
    FFA FINANCE LTD15/07/2009DissolvidaAccountantDiretor
    Beechcroft Road
    SW17 7BW London
    64
    United KingdomFrench
    FH CONSULTING SERVCES LTD10/06/2009DissolvidaAccountantDiretor
    Beechcroft Road
    SW17 7BY London
    64
    England
    United KingdomFrench
    MAPAH INVESTMENTS LTD23/03/2006AtivaAccountantDiretor
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    EnglandFrench
    MAPAH INVESTMENTS LTD23/03/2006AtivaSecretário
    c/o 66 Pah
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    French
    66 PROFESSIONAL SERVICES LTD31/07/2002AtivaAccountantDiretor
    Hill Street
    W1J 5NG London
    8
    England
    United KingdomFrench
    VIARENTIS PROPERTY MANAGEMENT LTD20/11/201522/02/2018AtivaAccountantDiretor
    Sudbrooke Road
    SW12 8TQ London
    64
    England
    EnglandFrench
    VECTRYSS LIMITED08/09/201522/02/2018AtivaAccountantDiretor
    78/79 New Bond Street
    W1S 1RZ London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandFrench
    VIAGEFI 5 LIMITED02/02/201730/01/2018AtivaAccountantDiretor
    160 Victoria Street
    SW1E 5LB London
    9th Floor Nova South
    United Kingdom
    EnglandFrench
    VIAGEFI 4 LIMITED24/01/201730/01/2018AtivaAccountantDiretor
    Sudbrooke Road
    SW12 8TQ London
    64
    United Kingdom
    EnglandFrench
    VIAGEFI 1 LIMITED12/01/201730/01/2018AtivaAccountantDiretor
    New Bond Street
    W1S 1RZ London
    Floor 78-79
    United Kingdom
    EnglandFrench
    VIAGEFI 3 LIMITED11/01/201730/01/2018AtivaAccountantDiretor
    78-79 New Bond Street
    W1S 1RZ London
    Floor 4
    EnglandFrench
    VIAGEFI 6 LIMITED11/07/201430/01/2018AtivaFinance DirectorDiretor
    Sudbrooke Road
    SW12 8TQ London
    64
    United Kingdom
    EnglandFrench
    VIAGEFI 5 LIMITED02/07/201409/04/2015AtivaFinance DirectorDiretor
    Hopton Road
    SW16 2ER London
    12 Russell Court
    England
    United KingdomFrench
    BUTTERSCOTCH SERVICES LTD08/07/200922/12/2014DissolvidaAccountantDiretor
    Hopton Road
    SW16 2ER London
    12 Russell Court
    England
    United KingdomFrench
    TNT DEVELOPMENT GROUP LTD01/09/200905/06/2014AtivaAccountantDiretor
    Hopton Road
    SW16 2ER London
    12 Russell Court
    England
    United KingdomFrench
    HBV LONDON LTD01/11/201205/06/2014DissolvidaDirectorDiretor
    Carlingford Gardens
    CR4 2AT Mitcham
    29
    Surrey
    United Kingdom
    UkFrench
    SW LONDON COMMERCIAL LTD21/10/200905/06/2014DissolvidaAccountantDiretor
    Carlingford Gardens
    CR4 2AT Mitcham
    29
    Surrey
    England
    UkFrench
    DGC NOMINEE DIRECTORS LIMITED18/11/200819/05/2014DissolvidaDirectorDiretor
    Carlingford Gardens
    CR4 2AT Mitcham
    29
    Surrey
    England
    UkFrench
    DGC NOMINEE SHAREHOLDER LIMITED10/06/200519/05/2014DissolvidaAccountantDiretor
    Carlingford Gardens
    CR4 2AT Mitcham
    29
    Surrey
    England
    UkFrench
    DGC NOMINEE SECRETARIES LIMITED30/12/200419/05/2014DissolvidaAccountantDiretor
    Carlingford Gardens
    CR4 2AT Mitcham
    29
    Surrey
    UkFrench
    WELLCOM SERVICES LTD24/08/201112/11/2013AtivaAccountantDiretor
    Beechcroft Road
    SW17 7BY London
    64
    United Kingdom
    United KingdomFrench
    POOKEE CONSULTING LTD08/09/200901/01/2013DissolvidaAccountantDiretor
    Beechcroft Road
    SW17 7BY London
    64
    United KingdomFrench
    OCTAGE LIMITED15/07/200903/12/2012DissolvidaAccountantDiretor
    Beechcroft Road
    SW17 7BY London
    64
    United KingdomFrench
    DUMAS & CIE LIMITED14/11/201214/11/2012DissolvidaAccountantDiretor
    Harbour Yard
    Chelsea Harbour
    SW10 0XD London
    202
    United Kingdom
    United KingdomFrench
    CAR LOUNGE INTERNATIONAL LIMITED26/10/201226/10/2012DissolvidaAccountantDiretor
    Harbour Yard
    Chelsea Harbour
    SW10 0XD London
    202
    United Kingdom
    United KingdomFrench
    EXQUISE MOTORS LIMITED25/10/201225/10/2012DissolvidaAccountantDiretor
    Harbour Yard
    Chelsea Harbour
    SW10 0XD London
    202
    United Kingdom
    United KingdomFrench

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0