Gerald Maurice KRASNER
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Gerald Maurice KRASNER

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeGerald
    Segundo NomeMaurice
    Último NomeKRASNER
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo8
    Inativo6
    Renunciado25
    Total39

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    AX-AI LTD27/09/2023AtivaDiretor
    The Watermark
    Bankside
    NE11 9SY Gateshead
    Unit 4
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    EnglandBritish
    MYLEARNING SOFTWARE LIMITED30/06/2023AtivaDiretor
    The Watermark
    Bankside
    NE11 9SY Gateshead
    Unit 4
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    EnglandBritish
    BARTHOLOMEW TRUSTEE COMPANY LTD23/02/2021AtivaDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    TEASE HAIR UK LTD19/01/2021AtivaDiretor
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Panoramic House Bankside
    England
    EnglandBritish
    SBA NATIONWIDE LIMITED16/01/2019LiquidaçãoDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    PANORAMIC SERVICES LIMITED04/01/2019AtivaDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    GO-CENTRIC LIMITED14/11/2018LiquidaçãoDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    GMK SPORTING SERVICES LIMITED16/06/2014AtivaDiretor
    Manse Lane
    HG5 8NQ Knaresborough
    Monkswell House
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish
    CARLETON RISK MANAGEMENT LIMITED05/01/2007DissolvidaSecretário
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    British
    THE HOMEFINDER GROUP LIMITED18/08/2006DissolvidaDiretor
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish
    SJB COMMERCIAL LIMITED18/08/2006DissolvidaDiretor
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish
    HOMEFINDER U.K. LIMITED18/08/2006DissolvidaDiretor
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish
    HOMEFINDER UNI LIMITED18/08/2006DissolvidaDiretor
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish
    HOMEFINDER WORLDWIDE LIMITED18/08/2006DissolvidaDiretor
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish
    POWERS (NI) LIMITED15/05/200725/09/2024AtivaDiretor
    Cromac Square
    BT2 8LA Belfast
    Forsyth House
    Northern Ireland
    United KingdomBritish
    POWERS LIMITED15/05/200625/09/2024AtivaDiretor
    Highgate
    DH1 4GA Durham
    60
    England
    United KingdomBritish
    SECURECRUIT LTD22/07/202101/04/2023DissolvidaDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    VALHALLA TRAINING & SECURITY LTD01/09/202126/11/2022DissolvidaDiretor
    Castle Laurie Works
    Falkirk
    FK2 7XE Bankside
    Ironworks Business Centre
    Scotland
    EnglandBritish
    FIRST IN HEALTHCARE LIMITED23/12/202101/06/2022AtivaDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    VTS SOLUTIONS LIMITED14/12/202118/05/2022DissolvidaDiretor
    Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HE Newcastle Upon Tyne
    22
    England
    EnglandBritish
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP01/11/200730/04/2022AtivaMembro da LLP
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PP Newcastle-Upon-Tyne
    United Kingdom
    United Kingdom
    CHELSEA STAFF BUREAU LIMITED01/09/202131/03/2022DissolvidaDiretor
    New Kings Road
    SW6 4LZ London
    Melon Accountants Ltd, Suite Lg5, 136-144
    England
    EnglandBritish
    TW PROPERTY 2019 LTD21/06/201908/07/2019DissolvidaDiretor
    Grovehill Road
    RH1 6DB Redhill
    79
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    TW PROPERTY 2019 LTD17/06/201918/06/2019DissolvidaDiretor
    Highgate
    DH1 4GA Durham
    60
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    GLAMOURGRANANN LIMITED31/05/201804/01/2019AtivaDiretor
    23 Park Square
    LS1 2ND Leeds
    C/O Ground Floor St Paul's House
    England
    United KingdomBritish
    DCR-IT LTD20/11/201803/12/2018DissolvidaDiretor
    Highgate
    DH1 4GA Durham
    60
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    MAKE YOUR FUTURE LIMITED14/09/201804/11/2018DissolvidaDiretor
    Highgate
    DH1 4GA Durham
    60
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    TWENTYCO LIMITED13/10/201701/08/2018AtivaDiretor
    23 Park Square
    LS1 2ND Leeds
    Ground Floor, St Paul's House
    England
    United KingdomBritish
    MJC INTERNATIONAL LIMITED04/06/201513/02/2017DissolvidaDiretor
    Headingley Office Park
    8 Victoria Road
    LS6 1PF Leeds
    4th Floor Stockdale House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    M J TELWORLD LIMITED04/06/201513/02/2017DissolvidaDiretor
    Headingley Office Park
    8 Victoria Road
    LS6 1PF Leeds
    4th Floor Stockdale House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    118 117 .COM LIMITED04/06/201513/02/2017DissolvidaDiretor
    Headingley Office Park
    8 Victoria Road
    LS6 1PF Leeds
    4th Floor Stockdale House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    TURTON GROUP TRADING LIMITED10/09/201431/10/2016AtivaDiretor
    Pennine View
    Birstall
    WF17 9NF Batley
    Sovereign House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish
    TURTON GROUP INVESTMENTS LIMITED10/09/201431/12/2015AtivaDiretor
    Pennine View
    Birstall
    WF17 9NF Batley
    Sovereign House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish
    INGENIOUS FILM PARTNERS LLP18/02/200506/04/2010AtivaMembro da LLP
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PP Newcastle-Upon-Tyne
    United Kingdom
    United Kingdom
    CARLETON RISK MANAGEMENT LIMITED05/01/200720/11/2009DissolvidaDiretor
    11 Carlton Terrace
    Jesmond
    NE2 4PQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0